Loading...
HomeMy WebLinkAboutAGENDA - 07242012 -               CALENDAR FOR THE BOARD OF SUPERVISORS CONTRA COSTA COUNTY AND FOR SPECIAL DISTRICTS, AGENCIES, AND AUTHORITIES GOVERNED BY THE BOARD BOARD CHAMBERS ROOM 107, ADMINISTRATION BUILDING, 651 PINE STREET MARTINEZ, CALIFORNIA 94553-1229 MARY N. PIEPHO, CHAIR, 3rd DISTRICT JOHN GIOIA, 1st DISTRICT CANDACE ANDERSEN, 2nd DISTRICT KAREN MITCHOFF, 4th DISTRICT FEDERAL D. GLOVER, 5th DISTRICT DAVID J. TWA, CLERK OF THE BOARD AND COUNTY ADMINISTRATOR, (925) 335-1900 The Board of Supervisors respects your time, and every attempt is made to accurately estimate when an item may be heard by the Board. All times specified for items on the Board of Supervisors agenda are approximate. Items may be heard later than indicated depending on the business of the day. Your patience is appreciated. AGENDA July 24, 2012                  9:00 A.M.  Convene and adjourn to Closed Session in Room 101.    Closed Session Agenda : A. CONFERENCE WITH LABOR NEGOTIATORS 1. Agency Negotiators: David Twa and Ted Cwiek. Employee Organizations: Contra Costa County Employees’ Assn., Local No. 1; Am. Fed., State, County, & Mun. Empl., Locals 512 and 2700; Calif. Nurses Assn.; Service Empl. Int’l Union, Local1021; District Attorney’s Investigators Assn.; Deputy Sheriffs Assn.; United Prof. Firefighters, Local 1230; Physicians’ & Dentists’ Org. of Contra Costa; Western Council of Engineers; United Chief Officers Assn.; Service Empl. Int’l Union United Health Care Workers West; East County Firefighters’ Assn.; Contra Costa County Defenders Assn.; Probation Peace Officers Assn. of Contra Costa County; Contra Costa County Deputy District Attorneys’ Assn.; and Prof. & Tech. Engineers, Local 21, AFL-CIO. 2. Agency Negotiators: David Twa and Ted Cwiek. Unrepresented Employees: All unrepresented employees. B. CONFERENCE WITH LEGAL COUNSEL--EXISTING LITIGATION (Gov. Code, § 54956.9(a)) 1. Sharon Goldsmith v. Contra Costa County, WCAB #’s ADJ-4673035, 4466307, 4713984 2. Contra Costa County Flood Control & Water Conservation District v. Camara, et al. Contra Costa Superior Court Case No. C10-02595 3. County of Contra Costa v. Bank of America, N.A., et al. (In re Municipal Derivatives Litigation - Case No. MDL 1950 (S.D.N.Y.) 4. Retiree Support Group of Contra Costa County v. Contra Costa County United States District Court Case No. C 12-00944  5. Board of Retirement of the Contra Costa County Employees’ Retirement Association v. County of Contra Costa, et al., Alameda Superior Court Case No. RG-11608520. July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 1   9:30 A.M.  Call to order and opening ceremonies.                    Inspirational Thought - "Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action." ~ Benjamin Disraeli   CONSIDER CONSENT ITEMS (Items listed as C.1 through C.89 on the following agenda) – Items are subject to removal from Consent Calendar by request of any Supervisor or on request for discussion by a member of the public. Please note: items removed from this section will be calendared for the July 31, 2012 Board of Supervisors meeting date.   SHORT DISCUSSION ITEMS           SD. 1    PUBLIC COMMENT (3 Minutes/Speaker)           SD. 2    CONSIDER Consent Items previously removed.   SD. 3 CONSIDER adopting Resolution No. 2012/311 approving the updated Memorandum of Understanding (MOU) between Contra Costa County and the Public Employees Union, Local 1 – CSB – Site Supervisor Unit (Local 1 - CSB) for the period of July 1, 2011 through June 30, 2013 and superseding the MOU adopted on January 24, 2012 in Resolution No. 2012/34. (Ted Cwiek, Human Resources Director)   SD. 4 CONSIDER adopting Resolution No. 2012/310 approving the updated Memorandum of Understanding (MOU) between Contra Costa County and the Public Employees Union, Local 1 (Local 1) for the period of July 1, 2011 through June 30, 2013 and superseding the MOU adopted on January 24, 2012 in Resolution No. 2012/34. (Ted Cweik, Human Resources Director)   SD. 5 CONSIDER approving a response to Civil Grand Jury Report No. 1216, entitled "Operational Effectiveness"; and DIRECT the Clerk of the Board to forward response to the Superior Court by August 11, 2012. (David Twa, County Administrator)   SD. 6 CONSIDER approving the response to Civil Grand Jury Report No. 1212, entitled, "Help for the Homeless" and DIRECT the Clerk of the Board to forward the response to the Superior Court no later than August 6, 2012.  (David Twa, County Administrator's Office)   10:00 A.M.   SD. 7 HEARING to consider approving and authorizing the Chair, Board of Supervisors, to execute the Purchase and Sale Agreement in the amount of $252,500 for the real property located at 211 C Street, Martinez, and adopt related California Environmental Quality Act (CEQA) findings, as recommended by the Public Works Director, Martinez area. (100% Enterprise Fund I) (Carmen July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 2 Pina-Sandoval, Public Works)   DELIBERATION ITEMS           D. 1    CONSIDER reports of Board members.   Closed Session   CONSENT ITEMS   Road and Transportation   C. 1 ADOPT Traffic Resolution No. 2012/4363 to prohibit parking on the west side of Highland Boulevard (Road No. 1655AK), Kensington area, as recommended by the Public Works Director. (No Fiscal Impact)   C. 2 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director or designee, to execute the license agreement between Contra Costa County and Contra Costa Centre Transit Village Association for the Contra Costa Centre Wayfinding Program as recommended by the Public Works Director, Walnut Creek area. (No Fiscal Impact)   C. 3 ACCEPT the 2012 Semi Annual Acceptance Report of real property acquisitions approved by the Public Works Director as submitted, Countywide. (No Fiscal Impact)   C. 4 AWARD and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a construction contract in the amount of $1,295,411 with Ghilotti Bros., Inc., with waiver of a Project Labor Agreement, for the Kirker Pass Road Overlay project, Pittsburg area. (88.5% Federal STIP (State Transportation Improvement Program) Funds and 11.5% Local Road Funds)   C. 5 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Public Works Department, to execute a Purchase Order with Helena Chemical Company, in an amount not to exceed $200,000, for the purchase of vegetation management chemicals, for the period from August 1, 2012 through August 31, 2014, Countywide. (100% Local Road and Flood Control Funds)     C. 6 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Public Works Department, to execute a Purchase Order with Crop Production Services, in an amount not to exceed $200,000, for the purchase of vegetation management chemicals, for the period from August 1, 2012 through August 31, 2014, Countywide. (100% Local Road and Flood Control Funds)     C. 7 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Public July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 3 C. 7 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Public Works Department, to execute a Purchase Order with Reed Graham, in an amount not to exceed $350,000, for the purchase of PMCRS-2H (Polymer Modified Cationic Rapid Set) asphalt emulsion including spreading and delivery, for the 2012 Fabric Patching Program, Countywide. (100% Local Road Funds)   Engineering Services   C. 8 ADOPT Resolution No. 2012/314 approving and authorizing the Public Works Director, or designee, to fully close a portion of Orwood Road approximately 2.5 miles east of Bixler Road, for five (5) consecutive working days between July 25, 2012 and August 24, 2012 from 7:00 A.M. through 5:00 P.M., for the purpose of the removal of petroleum impacted soil, Brentwood area. (No Fiscal Impact)   C. 9 ADOPT Resolution No. 2012/315 accepting completion of warranty period and release of cash deposit for faithful performance, Drainage Improvement Agreement DG 00-0005 (cross-reference subdivision SD 95-07976), as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (100% Developer Fees)   C. 10 ADOPT Resolution No. 2012/316 accepting completion of private improvements for Subdivision Agreement MS 03-00028, for project being developed by Robert A. Pritzkow and Elaine Pritzkow, and Vinod Wadhawan and Kiran Wadhawan, as recommended by the Public Works Director, Bay Point area. (100% Developer Fees)   C. 11 ADOPT Resolution No. 2012/317 accepting completion of warranty period and release of cash deposit for faithful performance for the Subdivision Agreement (Right-of-Way Landscaping), subdivision SD 03-08710, as recommended by the Public Works Director, Discovery Bay area. (100% Developer Fees)   C. 12 ADOPT Resolution No. 2012/318 accepting completion of landscape improvements for Drainage Improvement Agreement DG 00-00006, for a project being developed by Windemere BLC Land Company, LLC, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area.  (100% Developer Fees)   C. 13 ADOPT Resolution No. 2012/319 accepting completion of warranty period and release of cash deposit for faithful performance for the Subdivision Agreement (Right-of-Way Landscaping) for road acceptance RA 05-01204, as recommended by the Public Works Director, Discovery Bay area.  (District III)  (100% Developer Fees)   C. 14 ADOPT Resolution No. 2012/320 accepting completion of improvements for July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 4 C. 14 ADOPT Resolution No. 2012/320 accepting completion of improvements for Subdivision Agreement SD 05-09037 for a project being developed by Shapell Homes, A Division of Shapell Industries, Inc., a Delaware Corporation, as recommended by the Public Works Director, Danville area. (100% Developer Fees)   C. 15 ADOPT Resolution No. 2012/321 accepting completion of warranty period and release of cash deposit for faithful performance, Drainage Improvement Agreement DG 02-00018, for a project being developed by Windemere BLC Land Company, LLC, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (100% Developer Fees)   C. 16 ADOPT Resolution No. 2012/322 approving and authorizing the Public Works Director, or designee, to fully close a portion of 2nd Street between Parker Avenue and John Street, on August 11, 2012 from 10:00 A.M. through 5:00 P.M., for the purpose of Stop the Violence/Back to School block party, Rodeo area. (No Fiscal Impact)   C. 17 ADOPT Resolution No. 2012/323 accepting completion of warranty period and release of cash deposit for faithful performance, Road Improvement Agreement RA 05-01200, for a project being developed by Windemere BLC Land Company, LLC, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (100% Developer Fees)   C. 18 ADOPT Resolution No. 2012/324 accepting completion of warranty period and release of cash deposit for faithful performance, Drainage Improvement Agreement DG 00-00007, for a project being developed by Windemere BLC Land Company, LLC, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (100% Developer Fees)   C. 19 ADOPT Resolution No. 2012/325 accepting completion of warranty period and release of cash deposit for faithful performance, Road Improvement Agreement RA 02-01133, for a project being developed by Windemere BLC Land Company, LLC, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (100% Developer Fees)   Special Districts & County Airports   C. 20 APPROVE and AUTHORIZE the Director of Airports, or designee, on behalf of the County, to (i) terminate the lease between the County and Caffino Express LLC (“Caffino”) dated October 1, 2010, and (ii) initiate an unlawful detainer proceeding against Caffino to regain possession of 2301 Meridian Park Boulevard, Buchanan Field Airport. Concord Area (100% Airport Enterprise Fund)   C. 21 APPROVE AND AUTHORIZE the Chair, Board of Supervisors, to execute a July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 5 C. 21 APPROVE AND AUTHORIZE the Chair, Board of Supervisors, to execute a Grant of Easement to East Contra Costa Irrigation District, and ACCEPT a Quitclaim Deed from East Contra Costa Irrigation District over portions of Assessor Parcel Number 019-070-001, located off Fairview Court, Brentwood Area, as recommended by the Chief Engineer, Flood Control and Water Conservation District. (No Fiscal Impact).   C. 22 ADOPT Resolution No. 2012/312 to support Walnut Creek Watershed Council activities, AUTHORIZE staff support for a Walnut Creek Watershed Council, and APPROVE $10,000 funding to match a grant for preparation of the Walnut Creek Watershed Inventory, as recommended by the Chief Engineer, Flood Control and Water Conservation District, Walnut Creek area. (100% Flood Control District Zone 3B Funds)   Claims, Collections & Litigation   C. 23 DENY claims filed by AAA NCNU IE for Sharon Cobb, Mary Arnold, Richard Boles, Debra Carmel, Mayrdawna Davis, Jazmin Del Toro, Juanita Hinds, Shokouk Mahmoudi, Carolyn Marshall, John Farrow, Jeanne Pietrok, Kenneth Smith, Michael and Lori Trevino, Larry Vardanega, and Diana Voloveskay; DENY application to file late claim by Diana Voloveskay; and DENY amended claims filed by Melanie Latronica and Shokouk Mahmoudi.   C. 24 APPROVE and AUTHORIZE County Counsel or designee to execute on behalf of the County a conflict waiver acknowledging a potential conflict of interest and consenting to Meyers Nave representing the City of El Cerrito in connection with potential claims against the County Auditor-Controller related to implementation of AB 1484.   C. 25 RECEIVE public report of litigation settlement agreements that became final during the period of June 1, 2012 through June 30, 2012, as recommended by County Counsel.   Statutory Actions   C. 26 ACCEPT Board member meeting reports for June 2012.   Honors & Proclamations   C. 27 ADOPT Resolution No. 2012/313 honoring the 52nd Annual Contra Costa County Championship Swim Meet, as recommended by Supervisor Andersen.   C. 28 ADOPT Resolution No. 2012/328 to proclaim July 15-21, 2012 as Probation, July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 6 C. 28 ADOPT Resolution No. 2012/328 to proclaim July 15-21, 2012 as Probation, Parole and Community Supervision Officer's Week in Contra Costa County, as recommended by the County Probation Officer.   Ordinances   C. 29 INTRODUCE Ordinance No. 2012-07 to exempt from the Merit System the newly established classifications of Executive Assistant I to the County Administrator-Exempt and Executive Assistant II to the County Administrator-Exempt, and delete the Executive Assistant to the County Administrator from the list of excluded classes in the Office of the County Administrator, waive reading, and fix July 31, 2012 for adoption.   Appointments & Resignations   C. 30 AMEND Board action of June 26, 2012 (Item C30), which declared a vacancy in Low Income Seat No. 2 on the Economic Opportunity Council, to change the seat number designation to Low Income Seat No. 4.   Appropriation Adjustments   C. 31 Agriculture (0335)/Public Works (0063):  APPROVE Appropriation Adjustment No. 5081 authorizing the transfer of appropriations in the amount of $31,261 from the Agriculture Department to Public Works, Fleet Operations to to purchase a new motorized weight cart.   Intergovernmental Relations   C. 32 AUTHORIZE the Chair of the Board of Supervisors to sign a letter to the author of Assembly Bill 1779 (inter-city rail agreements), the Hon. Cathleenn Galgiani, requesting that the Contra Costa Transportation Authority be made the appointing body to select the Contra Costa representative on a proposed Joint Powers Authority for the San Joaquin inter-city rail service, as recommended by the Transportation, Water and Infrastructure Committee.   Personnel Actions   C. 33 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21120 to revise and retitle the classification of Ambulatory Care Registration Manager (represented) to Registration and Staffing Manager (represented) in the Health Services Department. (No fiscal impact)   C. 34 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21115 to re-title the classification of July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 7 C. 34 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21115 to re-title the classification of Executive Assistant To The County Administrator - Exempt to Executive Assistant II To The County Administrator - Exempt in the office of the County Administrator. (No fiscal impact)   C. 35 ADOPT Position Adjustment Resolution #21121 to add one Permanent Intermittent Environmental Health Specialist I position (represented) in the Health Services Department. (100% Inspection Fees and reduction in overtime)   C. 36 ADOPT Position Adjustment Resolution #21122 to add one full time and one part time Mental Health Employment Placement Specialist positions (represented) in the Health Services Department. (100% Mental Health Services Act)   C. 37 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21116 to decrease the hours of one Board of Supervisors Assistant – General Secretary position; and to increase the hours of one Board of Supervisors Assistant – General Secretary position in the District II Board of Supervisors Office. (Cost Savings)   C. 38 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21118 to reallocate on the Salary Schedule the classifications of Undersheriff-Exempt (unrepresented) and Assistant Sheriff-Exempt (unrepresented), and their incumbents.  (100% County General Fund, Budgeted)   C. 39 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21117 to add one Deputy Sheriff-40 Hour (represented) position to the Field Operations Bureau in the Office of the Sheriff.  (100% Contra Costa Water District funds/Los Vaqueros Reservoir, Budgeted) (Consider with C. 43)   Leases   C. 40 APPROVE and AUTHORIZE the Director of Public Works, or designee, to execute a License Agreement with the Judicial Council of California, Administrative Office of the Courts for 476 square feet of office space at the Arnason Justice Center, 1000 Center Drive, Room 2082 and 2095, Pittsburg for the District Attorney and Public Defender, Pittsburg area. (100% General Funds, Budgeted)    Grants & Contracts   APPROVE and AUTHORIZE execution of agreements between the County and the following agencies for receipt of fund and/or services:   C. 41 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Department July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 8 C. 41 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Department Interim Director, or designee, to apply for and accept U.S. Department of Commerce, Economic Development Administration funding for the Advanced Manufacturing Jobs and Innovation Acceleration Challenge grant in an amount not to exceed $800,000 for the period November 1, 2012 through October 31, 2015. (50% non-federal match or in-kind match)   C. 42 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with California Department of Mental Health and Health Care Services, to pay the County an amount not to exceed $83,824,316, for the provision of Managed Mental Health Care for Medi-Cal Eligible residents, for the period from April 1, 2012 through December 31, 2012. (No County match)   C. 43 APPROVE and AUTHORIZE the Sheriff-Coroner, or designee, to execute a contract, including mutual indemnification, with the Contra Costa Water District in an amount not to exceed $300,000 to provide law enforcement services at the Los Vaqueros Reservoir for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  ($300,000 Revenue, no net County cost; Budgeted) (Consider with C. 39)   C. 44 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with First 5 Contra Costa Children and Families Commission, effective July 1, 2012, to increase the amount payable to County by $143,450 to a new total payment limit of $430,350, to provide additional funds to continue the Home Visiting Program and to extend the term from June 30, 2012 through December 31, 2012. (No County funds)   C. 45 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute and transmit an application to the U. S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration for funding in an amount not to exceed $600,000, for the Strategic Prevention Framework State Incentive Grant Project, for the period from April 1, 2012 through September 28, 2015. (No County match required)   C. 46 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with the U. S. Department of Veteran Affairs Northern California Health Care System, effective August 10, 2012, to increase the amount payable to the County by $28,420 to a new amount not to exceed $203,954, to provide additional services to homeless veterans, including associated operating cost of the West County’s Adult Interim Housing Program in Richmond and to extend the term from August 10, 2012 to September 30, 2012. (No County match required)   C. 47 APPROVE and AUTHORIZE the Sheriff-Coroner, or designee, to execute a contract with the West Contra Costa Unified School District to pay the County an amount not to exceed $227,175 to provide school resource officer services for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (Budgeted, no net County cost)   APPROVE and AUTHORIZE execution of agreement between the County and the July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 9 APPROVE and AUTHORIZE execution of agreement between the County and the following parties as noted for the purchase of equipment and/or services:   C. 48 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a contract with Massone Mechanical, Inc., in an amount not to exceed $220,000 for refrigeration repair work for the period July 1, 2012 through June 30, 2015. (100% Facilities Maintenance funds)   C. 49 APPROVE and AUTHORIZE the Conservation and Development Director, or designee, to execute required legal documents to provide $1,605,000 in HOME Investment Partnerships Act (HOME) funding to Lafayette Senior L.P., a California Limited Partnership, for the Lafayette Senior Apartment project in Lafayette. (100% HOME funds)   C. 50 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, or designee, to execute a Program Agreement and Blanket Purchase Order with Staples Contract and Commercial, Inc., in an amount not to exceed $6,000,000, for office supplies for the period September 1, 2012 through August 31, 2014. (100% County User Departments)   C. 51 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, or designee, to execute a Program Agreement and Blanket Purchase Order with MyOfficeProducts, Inc., in an amount not to exceed $9,000,000, for office supplies for the period September 1, 2012 through August 31, 2014. (100% County User Departments)   C. 52 APPROVE and AUTHORIZE the Conservation and Development Director, or designee, to execute a contract with Environmental Science Associates (ESA) in an amount not to exceed $400,000 to prepare an environmental impact report for the Phillips 66 Company Rodeo Refinery proposed "Fuel Gas Hydrotreating and Propane Recovery Plant Project" for the period July 24, 2012 through August 1, 2013. (100% Permit Application Fees; Rodeo Area)   C. 53 APPROVE and AUTHORIZE the Sheriff-Coroner, or designee, to execute a contract, including modified indemnification, with John Berk, D.D.S., in an amount not to exceed $10,000 to provide odontology consultation services for the period April 1, 2012 through May 31, 2014.  (100% General Fund, Budgeted)   C. 54 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Susan Martinez (dba God’s Grace Homes) in an amount not to exceed $184,800, to provide augmented board and care services, for the period from July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Mental Health Realignment funds.)   C. 55 APPROVE and AUTHORIZE the Director of Conservation and Development, or designee, to execute a tolling agreement with Verizon Wireless to extend the time to act on the permit application for the wireless telecommunication facility proposed for 2491 San Miguel Drive (Walnut Creek area). (No fiscal impact.)   July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 10   C. 56 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Philips Electronics North American Corporation, effective May 24, 2012, to increase the payment limit by $8,000 to a new payment limit of $55,000, to provide additional consultation, training, technical assistance, and support services for the Epic project, with no change in the original term of January 1, 2012 through December 31, 2012. (100% Medicare & Medicaid Electronic Health Records Incentive Program of the American Recovery & Reimbursement Act)   C. 57 APPROVE and AUTHORIZE the Conservation and Development Director, or designee, to execute required legal documents to provide $360,000 in HOME Investment Partnerships Act (HOME) funds to Habitat for Humanity East Bay/Silicon Valley, a California nonprofit public benefit corporation, for the Pleasant Creek Homes in Lafayette. (100% HOME funds)   C. 58 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute, a contract with the County of Santa Clara, in an amount not to exceed $50,000, for the provision of laboratory testing services for Contra Costa Regional Medical Center and Contra Costa Health Centers, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Enterprise I)   C. 59 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Merritt, Hawkins and Associates, in an amount not to exceed $300,000, to provide recruitment of physicians at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Enterprise Fund I)   C. 60 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute an contract amendment with Sarcom, Inc. (dba the Abreon Group), effective June 1, 2012, to modify the payment provisions to reflect the intent of the parties to allow Contractor to be reimbursed for additional expenses, with regard to the Epic Electronic Health Records Project, with no change to the original payment limit of $224,939 and no change to the original term of August 15, 2011 through August 15, 2012. (100% Enterprise Fund I)   C. 61 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Precyse Solutions, LLC, in an amount not to exceed $490,000, to provide temporary medical coding and tumor registrar services for Contra Costa Regional Medical Center and Contra Costa Health Centers, for the period from June 1, 2012 through May 31, 2013. (100% Enterprise Fund I)   C. 62 RATIFY on behalf of the County, a Facilities Use Agreement with the City of Brentwood, including modified indemnification  language, for the use of the Brentwood Community Center as a Senior Nutrition Program Café, for the period from July 1, 2012, though June 30, 2013. (No cost)   C. 63 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 11 C. 63 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Gemini Staffing, LLC, in an amount not to exceed $225,000, to provide temporary dental assistants at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, for the period February 1, 2012 through January 31, 2013. (100% Enterprise Fund I)   C. 64 APPROVE and AUTHORIZE County Risk Manager to execute a contract with Todd Boley, Attorney at Law, for legal services for the period of June 1, 2012 through July 1, 2013, in accordance with a specified fee schedule. (100% General Liability Internal Service Fund)   C. 65 APPROVE and AUTHORIZE the County Administrator, or designee, to execute a contract with Burr Pilger Mayer, Inc. in an amount not to exceed $106,580 for professional accounting services for the period of July 1, 2012 through June 30, 2015. (100% General Fund)   C. 66 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Intratek Computer, Inc., effective June 14, 2012, to increase the payment limit by $200,000 to a new payment limit of $463,000 to provide additional technical assistance and support services, with no change in the original term of January 1, 2012 through December 31, 2012. (100% Enterprise Fund I)   C. 67 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with DocuStream, Inc., effective July 1, 2012, to increase the payment limit by $175,000 to a new payment limit of $405,000 to provide additional services, with no change in the original term of November 1, 2011 through October 31, 2012. (100% Member premiums)   C. 68 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Aaron K. Hayashi, M.D., Inc. effective June 1, 2012, to increase the payment limit by $235,000 to a new payment limit of $1,575,000 to provide additional radiology on-call services at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2014. (100% Enterprise Fund I)   C. 69 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a novation contract with Rainbow Community Center of Contra Costa County in an amount not to exceed $764,000, to provide Mental Health Services Act Innovations Services, for the period August 1, 2012 through July 31, 2013, with a six-month automatic extension through January 31, 2014, in an amount not to exceed $382,000. (13% Federal Medi-Cal, 87% Mental Health Services Act)   C. 70 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Institute for Healthcare Improvement, in an amount not to exceed $419,756 to provide professional consultation and technical support services to the Contra Costa Regional Medical Center for the period from May 15, 2012 through May 14, 2013. (100% Enterprise I) July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 12   C. 71 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Dominic Ciotola (dba CPR Training Center) in an amount not to exceed $160,000, to provide instruction in cardiopulmonary resuscitation for selected staff at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, for the period July 1, 2012 through June 30, 2015. (100% Enterprise Fund I)   C. 72 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a novation contract with Addiction Research and Treatment, Inc. (dba Bay Area Addiction Research and Treatment) in an amount not to exceed $2,987,311, to provide methadone maintenance treatment services, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013, with a six-month automatic extension through December 31, 2013, in an amount not to exceed $1,493,656. (50% Federal Drug Medi-Cal, 50% State Drug Medi-Cal)   C. 73 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent to execute, on behalf of the Sheriff-Coroner, a purchase order with Bob Barker Company, Inc., in an amount not to exceed $240,000 to provide inmate clothing, shoes, bedding, personal use items and all other related products needed in County adult detention facilities for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (100% General Fund, Budgeted)   C. 74 APPROVE and AUTHORIZE the Sheriff-Coroner, or designee, to execute a contract with Alerting Solutions, Inc., in an amount not to exceed $3,445,951 to provide proprietary software maintenance for the County's Community Warning (Siren) System for the period July 24, 2012 through July 23, 2017. (No net County cost;  100% Certified Unified Program Administration funding)   C. 75 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a contract with Precision Paint & Collision, in an amount not to exceed $600,000, for automotive body damage repair and related mechanical repair work for the period June 1, 2012 through May 30, 2015. (100% Fleet Internal Services Fund)   C. 76 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee to execute a contract with Walker's Auto Body, in an amount not to exceed $200,000, for automotive body damage repair services, paint and related mechanical repair work, for the period June 1, 2012 through May 30, 2015. (100% Fleet Internal Services Fund)   C. 77 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent to execute, on behalf of the Sheriff-Coroner, a purchase order with Highland Wholesale Foods, Inc., in an amount not to exceed $145,000 to provide canned and frozen foods at the County's adult detention facilities for the period August 1, 2012 through July 31, 2013. (100% County General Fund, Budgeted)   C. 78 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, or designee, to execute a July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 13 C. 78 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, or designee, to execute a purchase change order on behalf of the Chief Information Officer, with AT&T Global Services increasing the payment limit by $75,000 to a new total not to exceed $353,389 for the procurement of upgrade of audio and video equipment at 30 Muir Road, Martinez. (100% Land Development Fund)   C. 79 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent to execute, on behalf of the Sheriff-Coroner, a purchase change order with Hammons Supply Company, to extend the termination date from June 30, 2012 to September 30, 2012 and increase the payment limit by $30,000 to a new payment limit of $705,000 for miscellaneous janitorial supplies used in the County's detention facilities.  (100% General Fund, Budgeted)   C. 80 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent to execute, on behalf of the Sheriff-Coroner, a purchase change order with Clean Source to extend the termination date from June 30, 2012 to September 30, 2012 and increase the payment limit by $52,000 to a new payment limit of $1,088,933 for miscellaneous janitorial supplies needed within the County's detention facilities. (100% General Fund, Budgeted)   Other Actions   C. 81 ADOPT Resolution No. 2012/335 authorizing the the issuance and sale of "Pittsburg Unified School District General Obligation Bonds, Election of 2010, Series C (2012)" by the Pittsburg Unified School District on its own behalf pursuant to Sections 15140 and 15146 of the Education Code, as permitted by Section 53508.7(c) of the Government Code, as recommended by the County Administrator.   C. 82 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to extend the CCWORKS (Contra Costa Works) Subsidized Employment Program to reimburse employers for participants in the program and contractual/financial agreements with employers from June 30, 2012 to June 30, 2013. (85% Federal, 15% State)   C. 83 DECLARE and ACCEPT the results for Contra Costa Employees' Retirement Association Board Election, conducted June 26, 2012, as recommended by the Clerk Recorder-Elections. (No fiscal impact)   C. 84 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 14 C. 84 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to issue Request for Proposal for an Automated Appointment Scheduling System in an amount not to exceed $800,000 for the period January 1, 2013 through December 31, 2014. (10% County, 45% State, 45% Federal)   C. 85 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Department Interim Director, or designee, to issue Request for Proposal for a Data Specialist in an amount not to exceed $180,000 for the period October 1, 2012 through September 30, 2013. (10% County, 45% State; 45% Federal)   C. 86 DECLARE  as surplus and AUTHORIZE  the Purchasing Agent, or designee, to dispose of fully depreciated vehicles no longer needed for public use as recommended by the Public Works Director.   C. 87 ADOPT Resolution No. 2012/327 confirming the Final Report for CSA EM-1 (County Service Area, Emergency Medical Services) and setting assessments to be collected with the Fiscal Year 2012/13 property taxes, as recommended by the Health Services Director.   C. 88 ADOPT Resolution No. 2012/309 authorizing the the issuance and sale of "Pittsburg Unified School District General Obligation Bonds, Election of 2010, Series B (2012)" by the Pittsburg Unified School District on its own behalf pursuant to Sections 15140 and 15146 of the Education Code, as permitted by Section 53508.7(c) of the Government Code, as recommended by the County Administrator.   C. 89 CONTINUE the emergency action originally taken by the Board of Supervisors on November 16, 1999 regarding the issue of homelessness in Contra Costa County, as recommended by the Health Services Director.   GENERAL INFORMATION The Board meets in all its capacities pursuant to Ordinance Code Section 24-2.402, including as the Housing Authority and the Successor Agency to the Redevelopment Agency. Persons who wish to address the Board should complete the form provided for that purpose and furnish a copy of any written statement to the Clerk. Any disclosable public records related to an open session item on a regular meeting agenda and distributed by the Clerk of the Board to a majority of the members of the Board of Supervisors less than 72 hours prior to that meeting are available for public inspection at 651 Pine Street, First Floor, Room 106, Martinez, CA 94553, during normal business hours. All matters listed under CONSENT ITEMS are considered by the Board to be routine and will be enacted by one motion. There will be no separate discussion of these items unless requested by a member of the Board or a member of the public prior to the time the Board votes on the motion to adopt.  Persons who wish to speak on matters set for PUBLIC HEARINGS will be heard when the Chair July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 15 calls for comments from those persons who are in support thereof or in opposition thereto. After persons have spoken, the hearing is closed and the matter is subject to discussion and action by the Board.  Comments on matters listed on the agenda or otherwise within the purview of the Board of Supervisors can be submitted to the office of the Clerk of the Board via mail: Board of Supervisors, 651 Pine Street Room 106, Martinez, CA 94553; by fax: 925-335-1913. The County will provide reasonable accommodations for persons with disabilities planning to attend Board meetings who contact the Clerk of the Board at least 24 hours before the meeting, at (925) 335-1900; TDD (925) 335-1915. An assistive listening device is available from the Clerk, Room 106. Copies of recordings of all or portions of a Board meeting may be purchased from the Clerk of the Board.  Please telephone the Office of the Clerk of the Board, (925) 335-1900, to make the necessary arrangements.   Forms are available to anyone desiring to submit an inspirational thought nomination for inclusion on the Board Agenda. Forms may be obtained at the Office of the County Administrator or Office of the Clerk of the Board, 651 Pine Street, Martinez, California. Applications for personal subscriptions to the weekly Board Agenda may be obtained by calling the Office of the Clerk of the Board, (925) 335-1900. The weekly agenda may also be viewed on the County’s Internet Web Page:  www.co.contra-costa.ca.us    STANDING COMMITTEES The Airport Committee (Supervisors Mary N. Piepho and Karen Mitchoff) meets on the fourth Monday of the month at 12:30 p.m. at Director of Airports Office, 550 Sally Ride Drive, Concord. The Family and Human Services Committee (Supervisors Federal D. Glover and Candace Andersen) meets on the first Monday of the month at 1:30 p.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Finance Committee (Supervisors John Gioia and Federal D. Glover) meets on the second Monday of the month at 1:30 p.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Internal Operations Committee (Supervisors Karen Mitchoff and Candace Andersen) meets on the second Monday of the month at 9:00 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Legislation Committee (Supervisors Mary N. Piepho and Karen Mitchoff) meets on the first Thursday of the month at 11:00 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 16 The Public Protection Committee (Supervisors Candace Andersen and Federal D. Glover) meets on the first Monday of the month at 11:00 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Transportation, Water & Infrastructure Committee (Supervisors Mary N. Piepho and Federal D. Glover) meets on the first Thursday of the month at 9:30 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez.   Airports Committee September 24, 2012  12:30 PM See above Family & Human Services Committee  August 6, 2012  1:30 PM See above Finance Committee  August 13, 2012  1:30 PM See above Internal Operations Committee  August 13, 2012  9:00 AM See above Legislation Committee  Cancelled  Cancelled See above Public Protection Committee  August 6, 2012  11:00 AM See above Transportation, Water & Infrastructure Committee  August 2, 2012  1:30 PM See above   PERSONS WHO WISH TO ADDRESS THE BOARD MAY BE LIMITED TO THREE (3) MINUTES AGENDA DEADLINE: Thursday, 12 noon, 12 days before the Tuesday Board meetings. Glossary of Acronyms, Abbreviations, and other Terms (in alphabetical order): Contra Costa County has a policy of making limited use of acronyms, abbreviations, and industry-specific language in its Board of Supervisors meetings and written materials. Following is a list of commonly used language that may appear in oral presentations and written materials associated with Board meetings: AB Assembly Bill ABAG Association of Bay Area Governments ACA Assembly Constitutional Amendment ADA Americans with Disabilities Act of 1990 AFSCME  American Federation of State County and Municipal Employees AICP American Institute of Certified Planners AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome ALUC Airport Land Use Commission AOD  Alcohol and Other Drugs ARRA  American Recovery & Reinvestment Act of 2009 BAAQMD Bay Area Air Quality Management District BART Bay Area Rapid Transit District BayRICS Bay Area Regional Interoperable Communications System BCDC Bay Conservation & Development Commission BGO  Better Government Ordinance BOS Board of Supervisors CALTRANS  California Department of Transportation CalWIN California Works Information Network CalWORKS California Work Opportunity and Responsibility to Kids CAER Community Awareness Emergency Response CAO  County Administrative Officer or Office CCCPFD (ConFire) Contra Costa County Fire Protection District CCHP Contra Costa Health Plan CCTA Contra Costa Transportation Authority CCRMC Contra Costa Regional Medical Center CCWD Contra Costa Water District CDBG Community Development Block Grant CFDA Catalog of Federal Domestic Assistance CEQA California Environmental Quality Act CIO Chief Information Officer COLA Cost of living adjustment ConFire (CCCFPD) Contra Costa County Fire Protection District CPA Certified Public AccountantJuly 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 17 CPA Certified Public Accountant CPI Consumer Price Index CSA County Service Area CSAC California State Association of Counties CTC California Transportation Commission dba doing business as EBMUD East Bay Municipal Utility District ECCFPD East Contra Costa Fire Protection District EIR Environmental Impact Report EIS Environmental Impact Statement EMCC Emergency Medical Care Committee EMS Emergency Medical Services EPSDT  Early State Periodic Screening, Diagnosis and Treatment Program (Mental Health) et al. et alii (and others) FAA Federal Aviation Administration FEMA  Federal Emergency Management Agency F&HS Family and Human Services Committee First 5 First Five Children and Families Commission (Proposition 10) FTE Full Time Equivalent FY Fiscal Year GHAD Geologic Hazard Abatement District GIS Geographic Information System HCD  (State Dept of) Housing & Community Development HHS (State Dept of ) Health and Human Services HIPAA  Health Insurance Portability and Accountability Act HIV Human Immunodeficiency Syndrome HOV High Occupancy Vehicle HR  Human Resources HUD  United States Department of Housing and Urban Development IHSS In-Home Supportive Services Inc. Incorporated IOC Internal Operations Committee ISO Industrial Safety Ordinance JPA Joint (exercise of) Powers Authority or Agreement Lamorinda Lafayette-Moraga-Orinda Area LAFCo  Local Agency Formation Commission LLC Limited Liability Company LLP Limited Liability Partnership Local 1 Public Employees Union Local 1 LVN Licensed Vocational Nurse MAC Municipal Advisory Council MBE Minority Business Enterprise M.D. Medical Doctor M.F.T. Marriage and Family Therapist MIS Management Information System MOE Maintenance of Effort MOU Memorandum of Understanding MTC Metropolitan Transportation Commission NACo National Association of Counties NEPA National Environmental Policy Act OB-GYN Obstetrics and Gynecology O.D. Doctor of Optometry OES-EOC  Office of Emergency Services-Emergency Operations Center OPEB Other Post Employment Benefits OSHA Occupational Safety and Health Administration PARS Public Agencies Retirement Services Psy.D. Doctor of Psychology RDA Redevelopment Agency RFI Request For Information RFP Request For Proposal RFQ Request For Qualifications RN Registered Nurse SB  Senate Bill SBE Small Business Enterprise SEIU Service Employees International Union SUASI  Super Urban Area Security Initiative SWAT  Southwest Area Transportation Committee TRANSPAC Transportation Partnership & Cooperation (Central) TRANSPLAN Transportation Planning Committee (East County) TRE or TTE Trustee TWIC Transportation, Water and Infrastructure Committee UASI  Urban Area Security Initiative VA Department of Veterans Affairs vs. versus (against) WAN Wide Area Network WBE Women Business Enterprise WCCTAC West Contra Costa Transportation Advisory Committee July 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 18