Loading...
HomeMy WebLinkAboutAGENDA - 06262012 -               CALENDAR FOR THE BOARD OF SUPERVISORS CONTRA COSTA COUNTY AND FOR SPECIAL DISTRICTS, AGENCIES, AND AUTHORITIES GOVERNED BY THE BOARD BOARD CHAMBERS ROOM 107, ADMINISTRATION BUILDING, 651 PINE STREET MARTINEZ, CALIFORNIA 94553-1229 MARY N. PIEPHO, CHAIR, 3rd DISTRICT JOHN GIOIA, 1st DISTRICT VACANT, 2nd DISTRICT KAREN MITCHOFF, 4th DISTRICT FEDERAL D. GLOVER, 5th DISTRICT DAVID J. TWA, CLERK OF THE BOARD AND COUNTY ADMINISTRATOR, (925) 335-1900 The Board of Supervisors respects your time, and every attempt is made to accurately estimate when an item may be heard by the Board. All times specified for items on the Board of Supervisors agenda are approximate. Items may be heard later than indicated depending on the business of the day. Your patience is appreciated. AGENDA June 26, 2012                  9:00 A.M.  Convene and adjourn to Closed Session in Room 101.    Closed Session Agenda : A. CONFERENCE WITH LABOR NEGOTIATORS 1. Agency Negotiators: David Twa and Ted Cwiek. Employee Organizations: Contra Costa County Employees’ Assn., Local No. 1; Am. Fed., State, County, & Mun. Empl., Locals 512 and 2700; Calif. Nurses Assn.; Service Empl. Int’l Union, Local1021; District Attorney’s Investigators Assn.; Deputy Sheriffs Assn.; United Prof. Firefighters, Local 1230; Physicians’ & Dentists’ Org. of Contra Costa; Western Council of Engineers; United Chief Officers Assn.; Service Empl. Int’l Union United Health Care Workers West; East County Firefighters’ Assn.; Contra Costa County Defenders Assn.; Probation Peace Officers Assn. of Contra Costa County; Contra Costa County Deputy District Attorneys’ Assn.; and Prof. & Tech. Engineers, Local 21, AFL-CIO. 2. Agency Negotiators: David Twa and Ted Cwiek. Unrepresented Employees: All unrepresented employees. B. CONFERENCE WITH LEGAL COUNSEL--EXISTING LITIGATION (Gov. Code, § 54956.9(a)) 1. Shari Miller v. County of Contra Costa, Contra Costa Superior Court Case No. C11-01239 2. Croskrey, et al. v. County of Contra Costa, et al.  USDC, Northern District, Case No. C73-0906 JCS 3. Castillo v. Moraga-Orinda Fire District, Contra Costa Superior Court Case No. C09-01320 C. CONFERENCE WITH LEGAL COUNSEL--ANTICIPATED LITIGATION Significant exposure to litigation pursuant to Gov. Code, § 54956.9(b): One potential case.   9:30 A.M.  Call to order and opening ceremonies.  June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 1 9:30 A.M.  Call to order and opening ceremonies.                    Inspirational Thought - "Dare to reach out your hand into the darkness, to pull another hand into the light." ~ Norman B. Rice   CONSIDER CONSENT ITEMS (Items listed as C.1 through C.161 on the following agenda) – Items are subject to removal from Consent Calendar by request of any Supervisor or on request for discussion by a member of the public.  Items removed from this section will be considered with the Short Discussion Items.   PRESENTATIONS (5 Minutes Each)          PR. 1    PRESENTATION to honor James Baldacci for his contributions to Contra Costa County. (Supervisor Mitchoff)(See C. 25)          PR. 2    PRESENTATION to honor Nancy J. Lillian for 25 years of dedicated service to Contra Costa County. (Glenn Howell, Animal Services Director)(See C. 26)          PR. 3    PRESENTATION to honor Joseph M. DeCosta for 25 years of dedicated service to Contra Costa County. (Glenn Howell, Animal Services Director)(See C. 27)   SHORT DISCUSSION ITEMS           SD. 1    PUBLIC COMMENT (3 Minutes/Speaker)           SD. 2    CONSIDER Consent Items previously removed.   SD. 3 CONSIDER requesting Governor Edmund G. Brown Jr. to appoint Candace Andersen, Supervisor-elect for District II, to serve the remaining term of office for deceased District II Supervisor Gayle B. Uilkema, as recommended by Chair Piepho.   SD. 4 CONSIDER a position of support for "The Schools and Local Public Safety Protection Act Version 3," the Governor's hybrid tax measure jointly sponsored by the California Federation of Teachers. (Supervisors Gioia and Mitchoff)   SD. 5 CONSIDER accepting actuarial valuation of future annual costs of proposed changes to Other Post-Employment Benefits, changing the County health care premium subsidy for employees represented by or retired from classifications that were represented by the California Nurses Association, as provided by Buck Consultants in letter of June 20, 2012. (Lisa Driscoll, County Administrator's Office)   SD. 6 CONSIDER AMENDING the Contra Costa County Deferred Compensation June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 2 SD. 6 CONSIDER AMENDING the Contra Costa County Deferred Compensation Plan (IRC §457) Section 8-Distributions, Withdrawals and Loans, and the Administrative Agreement with The Hartford to include a Loan Provision; AMENDING the Contra Costa County Deferred Compensation Plan Section 10-Direct Rollovers and Plan-to-Plan Transfers, to comply with current IRS regulations; and ADOPTING Resolution No. 2012/298 xxx    SD. 7 CONSIDER adopting Resolution No. 2012/264 approving the Memorandum of Understanding (MOU) between Contra Costa County and the California Nurses Association (CNA) for the period of May 1, 2012 through July 31, 2014.   SD. 8 CONSIDER Adopting Resolution No. 2012/267 approving the Side Letter between Contra Costa County and AFSCME, Local 512 implementing negotiated conditions of employment for employees in the Probation Supervisors Unit, for the period of July 1, 2012 through June 30, 2015. (Ted Cwiek, Human Resources Director)   SD. 9 CONSIDER Adopting Resolution No. 2012/268 approving the interim Memorandum of Understanding (MOU) between Contra Costa County and the California Nurses Association (CNA) implementing negotiated wage agreements and other economic terms and conditions of employment for specified employees in per-diem nursing classifications, for the period of May 15, 2012 through January 31, 2012. (Ted Cwiek, Human Resources Director)   SD. 10 ADOPT Resolution No. 2012/293, which supersedes Resolution No. 2012/121, regarding compensation and benefits for the County Administrator, County Elected and Appointed Department Heads, management, Exempt, and Unrepresented employees to reflect changes, as recommended by the Human Resources Director.  (Ted Cwiek, Human Resources Director)     10:00 A.M.   SD. 11 HEARING to consider adoption of Resolution No. 2012/170 to establish new, and increase current, animal services fees.  (Glenn Howell, Animal Services Director)     SD. 12 HEARING to ADOPT Resolution No. 2012/279 approving the County Flood Control and Water Conservation District Stormwater Utility Assessments for areas 1-18 for Fiscal-Year 2012/13, as recommended by the Chief Engineer, Flood Control and Water Conservation District, Countywide. (Tim Jensen, Public Works Department) (100% Stormwater Utility Area Assessments)   SD. 13 HEARING to adopt Resolution No. 2012/285 confirming the Tentative Report for CSA EM-1 (County Service Area Emergency Medical Services) and declaring intent to levy specified assessments to be collected with the Fiscal Year 2012/13 property taxes, as recommended by the Health Services Director. (Pat Frost, EMS Director)  June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 3   SD. 14 HEARING to ADOPT Resolution No. 2012/262 confirming the Fiscal Year 2012/2013 Annual Report for County Service Area L-100 (Countywide Street Lighting) to levy and collect service charges and authorizing the service charges to be placed on the Fiscal Year 2012/2013 property tax rolls, Countywide. (Susan Cohen, Public Works Department) (100% CSA L-100 Funds)   SD. 15 HEARING to ADOPT Resolution No. 2012/274 accepting the Fiscal Year 2012/2013 Final Engineer’s Report for Contra Costa County Discovery Bay West Parking District to levy and collect annual assessments and authorizing assessments to be placed on the Fiscal Year 2012/2013 property tax roll, Discovery Bay area. (Susan Cohen, Public Works Department) (100% Discovery Bay West Parking District Funds)   SD. 16 HEARING to ADOPT Resolution No. 2012/273 accepting the Fiscal Year 2012/2013 Annual Report for County Service Area M-28 (CSA M-28) (Willow Mobile Home Park Water District) to levy and collect annual water service charges and authorizing the service charges to be placed on the Fiscal Year 2012/2013 property tax roll, Bethel Island area. (Susan Cohen, Public Works Department) (100% CSA M-28 Funds)   SD. 17 HEARING to ADOPT Resolution No. 2012/276 accepting the Fiscal Year 2012/2013 Annual Report for County Service Area M-31 (CSA M-31) (Contra Costa Centre Redevelopment Area) to levy and collect the annual assessments and authorizing assessments to be placed on the Fiscal Year 2012/2013 property tax roll, Pleasant Hill BART area. (Susan Cohen, Public Works Department) (100% CSA M-31 Funds)   SD. 18 HEARING to ADOPT Resolution No. 2012/275 accepting the Fiscal Year 2012/2013 Annual Report for County Service Area M-30 (CSA M-30) to levy and collect the annual assessments and authorizing assessments to be placed on the Fiscal Year 2012/2013 property tax roll, Danville area. (Susan Cohen, Public Works Department) (100% CSA M-30 Funds)   DELIBERATION ITEMS           D. 1    CONSIDER reports of Board members.   ADJOURN in the memory of former Hercules Mayor Joe  Eddy McDonald and East Contra Costa Fire Protection District, Fire Engineer William "Willie" West.   Closed Session   1:30 P.M. ADJOURN to the Contra Costa County Fire Protection District meeting. June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 4   CONSENT ITEMS   Road and Transportation   C. 1 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a contract amendment with Nichols Consulting Engineers, Chtd., (Nichols) to extend the term from April 1, 2012 to November 30, 2012 and increase the payment limit by $25,000 to a new amount of $124,502 to incorporate revisions to the Operations and Maintenance Plan for the Clyde Pedestrian Path. (100% Navy Transportation Mitigation Funds)   C. 2 ADOPT Traffic Resolution No. 2012/4358 to prohibit parking at all times (red curb) on the north side of Magnolia Way (Road No. 3844B), beginning at a point 133 feet south of the south curb line of Poplar Drive (Road No. 3845BL) and extending west a distance of 197 feet, as recommended by the Public Works Director, Walnut Creek area. (No Fiscal Impact)   C. 3 ADOPT Traffic Resolution No. 2012/4359 to prohibit parking at all times except for vehicles of individuals with disabilities (blue curb) on the north side of Oak View Avenue (Road No. 1655C), beginning at a point 23 feet west of the west curb line of Colusa Avenue (Road No. 1452) and extending west a distance of 25 feet, as recommended by the Public Works Director, Kensington area. (No Fiscal Impact)   C. 4 ADOPT Traffic Resolution No. 2012/4360 to prohibit parking at all times except for vehicles of individuals with disabilities (blue curb) on the south side of Winslow Street (Road No. 2295AD), beginning at a point 480 feet east of the east edge of pavement of Bay Street (Road No. 2295AJ) and extending east a distance of 19 feet, as recommended by the Public Works Director, Crockett area. (No Fiscal Impact)   C. 5 AWARD and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a construction contract in the amount of $247,031 with Graham Contractors, Inc. for the 2012 Kensington Area Micro-Surfacing project, Kensington area. (100% Road funds)   C. 6 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a Right of Way Agreement with Contra Costa Transportation Authority outlining terms for the transfer of property to the State, Antioch area. (No fiscal impact)   C. 7 AWARD and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 5 C. 7 AWARD and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute two contracts in a not-to-exceed amount of $110,000 each with Carlson's Construction and Strole's Tri-Service for On-Call Walking Excavator Services for Various Road and Flood Control Maintenance Work, Countywide. (100% Local Road and Flood Control funds)   C. 8 ADOPT Resolution No. 2012/278 approving and authorizing the recommendation of the Public Works Director, or designee, for allocating the Transportation Development Act (TDA), Article 3 Funds totaling $1,070,182 for bicycle and pedestrian projects for Fiscal Year 2012/2013 and DIRECT the Public Works Director, or designee, to forward the list to the Metropolitan Transportation Commission (MTC) for final approval and allocation of funding effective July 1, 2012, Countywide. (100% TDA Article 3 Funds)   C. 9 AWARD and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a construction contract in the amount of $1,665,448 with Graham Contractors, Inc. for the 2012 Tara Hills Terminal Blend Cape Seal & North Richmond Slurry Seal project, Tara Hills and North Richmond area. (88% Road Funds and 12% CalRecycle Rubberized Asphalt Grant Funds)   C. 10 AWARD and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a construction contract in the amount of $149,198 with Malachi Paving & Grading, Inc. for the Market Avenue and Chesley Avenue Railroad Pedestrian Crossings, North Richmond area. (63% Section 130 Grade Crossing Improvement Program Funds, 22% Road Funds, and 15% Transportation Development Act Funds)   C. 11 ADOPT Resolution No. 2012/280 accepting as complete the contracted work performed by Grade Tech, Inc., for the Montalvin Manor Pedestrian and Transportation Access Improvements project, as recommended by the Public Works Director, Montalvin area.  (No fiscal impact)    Engineering Services   C. 12 ADOPT Resolution No. 2012/277 to accept completion of improvements for Subdivision Agreement 07-09189 and declare Inglewood Street and El Rincon Road as county roads, for project being developed by Habitat for Humanity East Bay, as recommended by the Public Works Director, Bay Point area. (100% Developer Fees)   C. 13 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or Designee, to advertise the Alamo Pedestrian Improvements Project and make related findings under the California Environmental Quality Act (CEQA), Alamo area.  (100% Local Road Funds)   June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 6 C. 14 APPROVE the West County Detention Center Solar Array Installation and Restoration Project, and make related findings under the California Environmental Quality Act (CEQA), Richmond area, as recommended by the Public Works Director. (100% Energy Efficiency Improvement Funds)   Special Districts & County Airports   C. 15 ADOPT Resolution No. 2012/272 to vacate and quitclaim a portion of a Contra Costa County Flood Control and Water Conservation District Easement along San Ramon Creek encumbering 363 Diablo Road, and make the related findings under the California Environmental Quality Act; as recommended by the Chief Engineer, Danville area. (100% Applicant Fee Funds)    C. 16 APPROVE and AUTHORIZE the Chair, Board of Supervisors to execute an Amendment to the Grant of Easement with Central Contra Costa Sanitary District recorded on July 1, 2009, for a 96-inch sewer pipe and a 10-inch recycled water pipe located within the Buchanan Field Airport, as recommended by the Public Works Director, Concord area. (No fiscal impact)   C. 17 ADOPT Resolution No. 2012/282 approving and authorizing the Chief Engineer, Flood Control and Water Conservation District, or designee, to impose the annual Drainage Area Benefit Assessments for Fiscal Year 2012/13 for Drainage Areas 67A, 75A, 76A, 520, 910, 1010, and 1010A, Walnut Creek, Oakley, Alamo, Danville, and San Ramon areas. (100% Drainage Area Benefit Assessment Funds)   C. 18 ADOPT Resolution No. 2012/283 approving deposit of $200,000 by the Contra Costa County Flood Control & Water Conservation District to the Flood Control Revolving Fund and approving a loan from the Flood Control Revolving Fund in the amount of $200,000 to Flood Control Zone 9 for various activities regarding Pinole Creek, as recommended by the Chief Engineer, Flood Control and Water Conservation District, Pinole area. (100% Flood Control District Funds)   C. 19 ADOPT Resolution No. 2012/284 approving deposit of $100,000 by the Contra Costa County Flood Control & Water Conservation District to the Flood Control Revolving Fund and approving a loan from the Flood Control Revolving Fund in the amount of $100,000 to Drainage Area 127 for maintenance of Rheem Creek, as recommended by the Chief Engineer, Flood Control and Water Conservation District, San Pablo area. (100% Flood Control District Funds)   C. 20 APPROVE and AUTHORIZE the Director of Airports, or designee, to execute, June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 7 C. 20 APPROVE and AUTHORIZE the Director of Airports, or designee, to execute, on behalf of the County, a lease amendment that permits the recording of a Memorandum of Lease related to a 2009 lease between the County, as lessor, and Byron Jet Center LLC, as tenant, for property located at Byron Airport.  APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute, on behalf of the County, a Memorandum of Lease between the County, as lessor, and Byron Jet Center LLC, as tenant, for the property known as 760 Osprey Court, Byron, California. (100% Airport Enterprise Fund)   Claims, Collections & Litigation   C. 21 DENY claims filed by Terrell E. Enis,Clark & Karla Fratus, Guy Gerrard, Sean Michael Henderson, Donna Oslin, Rashawnda Reed, Tracy Reed, Martha Ruiz & CSAA Insurance; DENY amended claim filed by Rashawnda Reed; and DENY applications for leave to present a late claim filed by Arthur L. Holden and Donna Oslin.   C. 22 RECEIVE report concerning personal property loss of Neal Price, Health Services employee in Hazardous Materials Unit; and AUTHORIZE payment from the Liability Internal Service Fund in the amount of $949.99. (100% Liability Internal Service Fund)   C. 23 RECEIVE public report of litigation settlement agreements that became final during the period of May 1, 2012 through May 31, 2012.   Statutory Actions   C. 24 ACCEPT Board member meeting reports for May 2012.   Honors & Proclamations   C. 25 ADOPT Resolution No. 2012/290 honoring James Baldacci for his contributions to Contra Costa County, as recommended by Supervisor Mitchoff. (See PR. 1)   C. 26 ADOPT Resolution No. 2012/288 honoring Nancy J. Lillian for her 25 years of dedicated service to Contra Costa County as recommended by the Animal Services Director. (See PR. 2)   C. 27 ADOPT Resolution No. 2012/289 honoring Joseph M. DeCosta for his 25 years of dedicated service to Contra Costa County as recommended by the Animal Services Director. (See PR. 3)   C. 28 ADOPT Resolution No. 2012/271 supporting renaming of the Eastshore State Park to McLaughlin Eastshore State Park, as recommended by Supervisor Gioia.   C. 29 ADOPT Resolution No. 2012/296 recognizing the Ambrose-Pittsburg Lions June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 8 C. 29 ADOPT Resolution No. 2012/296 recognizing the Ambrose-Pittsburg Lions Club on their 60th Anniversary, as recommended by Supervisor Glover.   Ordinances   ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21106 to establish the class of Executive Assistant I To The County Administrator- Exempt (unrepresented); and add one Executive Assistant I To The County Administrator - Exempt (unrepresented) position in the office of the County Administrator/Clerk of the Board (Budgeted). INTRODUCE Ordinance No. 2012-08 to establish the class of Executive Assistant I To The County Administrator - Exempt in the County Administrator's office, waive reading, and fix July 24, 2012 for adoption. (See C. 54)   Appointments & Resignations   C. 30 ACCEPT resignation of Melissa Alfaro, DECLARE a vacancy in Low-Income Seat No. 2 on the Economic Opportunity Council, and DIRECT the Clerk of the Board to post the vacancy, as recommended by the Employment and Human Services Interim Director.   C. 31 REAPPOINT Teresa Pasquini to the District 1 Family Member seat on the Contra Costa County Mental Health Commission to a three year term expiring on 6/30/15, as recommended by Supervisor Gioia.   C. 32 ACCEPT resignation of Robert Canchola , DECLARE a vacancy in the Member At Large Seat No. 20 on the Advisory Council on Aging, and DIRECT the Clerk of the Board to post the vacancy, as recommended by Employment and Human Services Interim Director.   C. 33 APPOINT Marylee Martinez to the Contra Costa Centre Municipal Advisory Council as recommended by Supervisor Mitchoff.   C. 34 APPOINT Dyana Bhandari to the At-Large #1 seat and Peter Maund to the At-Large #2 seat on the Arts and Culture Commission of Contra Costa County, with terms expiring on June 30, 2015, as recommended by the Famiy and Human Services Committee.   C. 35 DECLARE vacant the At Large Seat 3, previously held by Tique Lee Caul, on the Contra Costa Commission for Women due to resignation, and DIRECT the Clerk of the Board to post the vacancy.   C. 36 APPOINT Terry Speiker to the One-Stop Mandated Partner No. 3 seat and Ross Gerard to the Business No. 21 seat on the Workforce Development Board, as recommended by the Internal Operations Committee. June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 9   C. 37 APPOINT Joseph DeLuca to At-Large Seat 4, Simone Gikanga to At-Large Seat 5, and Ruth Fernandez to Seat 3 - Childhood Development/Childhood Education, on the Family and Children's Trust Committee, as recommended by the Family and Human Services Committee.   C. 38 APPOINT Don Bristol to the Business No. 3 seat on the Hazardous Materials Commission, as recommended by the Internal Operations Committee.   Appropriation Adjustments   C. 39 Treasurer-Tax Collector (0015)/Fleet ISF (0064):  APPROVE Appropriation and Revenue Adjustment No. 5077 authorizing the transfer of appropriations in the amount of $21,720 from the Office of the Treasurer-Tax Collector (0015) to the Fleet Internal Service Fund (0064) for the purchase of one additional ISF vehicle.   C. 40 APPROVE Appropriation Adjustment No. 5079 which would, (1) reduce FY 2011-12 revenue and expenditure appropriations in Land Development Fund, Plant Acquisition (112000-0114) by $11,828,565 to reflect unexpended and unneeded funds for the completed 30-40 Muir Rd. construction project; and, (2) APPROVE the appropriation of $350,000 in Land Development Fund, Plant Acquisition (112000-0114) to fund additional internal improvements undertaken by DCD at 40 Muir Rd. in Martinez that are in addition to the scope of the original project.   C. 41 Conservation and Development (0280):  APPROVE Appropriation and Revenue Adjustment No. 5078 authorizing new revenue in the amount of $43,143 from accumulated depreciation and estimated salvage in Conservation and Development (0280) and appropriate it for the purchase of two vehicles. (94% Accumulated Depreciation, 6% Sale of Equipment)   C. 42 Sheriff-Coroner (0255):  APPROVE Appropriations and Revenue Adjustment No. 5074, authorizing new revenue in the amount of $57,557 from special tax levy for zones within County Service Area P-6 for Fiscal Year 2011/12 and appropriating it for patrol services.   C. 43 Sheriff-Coroner (0255):  APPROVE Appropriations and Revenue Adjustment No. 5075 authorizing new revenue in the amount of $80,340 from the Office of Homeland Security and appropriating it for underwater detection equipment as authorized by the 2010 Port Security Grant.    C. 44 Plant Acquisition (0111)/Sheriff (0255)/General Services (0064):  APPROVE June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 10 C. 44 Plant Acquisition (0111)/Sheriff (0255)/General Services (0064):  APPROVE Appropriations Adjustment No. 5076 authorizing the transfer of appropriations in the amount of $217,615 from Plant Acquisition to be distributed as follows: $156,805 to General Services - Fleet Internal Services Fund for the purchase of four Ford Escape Utility Vehicles and equipment and $60,810 to the Sheriff Patrol Division for the purchase of radio equipment for the vehicles. (Consider with C.156)   Intergovernmental Relations   C. 45 ADOPT the Delta Needs List of projects the County may advance for future Delta-related funding efforts, as recommended by the Transportation, Water and Infrastructure Committee.   C. 46 SUPPORT AB 1712 (Beall): Minors and Non-minor Dependents: Out-of-Home Placement, a bill that is a technical clean-up measure relating to 2010’s Fostering Connections to Success Act, which extended foster care services to youth up to age 21 and helps the state draw down additional foster care funding from the federal government, as recommended by the Legislation Committee.   C. 47 SUPPORT AB 1442 (Wieckowski): Pharmaceutical Waste, a bill that would authorize the transportation of outdated or otherwise unsalable non-creditable pharmaceuticals, which are designated as medical waste, via a common carrier as recommended by the Legislation Committee.   C. 48 SUPPORT if amended ACA 18 (Swanson): Taxation: Parcel Tax, a resolution that proposes a constitutional amendment that would allow a city, county, or special district to impose, extend, or increase a parcel tax for the purpose of funding the maintenance or improvement of fire protection or police protection services with approval by a majority of voters in that city, county, or special district, as recommended by the Legislation Committee.   C. 49 AUTHORIZE a letter of authorization from the Chair of the Board for the submittal of an application to the California State Association of Counties' 2012 Challenge Awards, as recommended by the County Administrator.   Personnel Actions   C. 50 ADOPT Position Resolution No. 20955 to establish the classification of Supervising Cytotechnologist (represented); reclassify Senior Cytotechnologist (represented) position and its incumbent to the new class;  and add four Laboratory Technician III (represented) positions  in the Laboratory Division at Contra Costa Regional Medical Center.  (100% Medi-Cal)   C. 51 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21093, to add one 30/40 Account June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 11 C. 51 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21093, to add one 30/40 Account Clerk-Experienced Level (represented) position and cancel a Clerk-Senior Level position (represented) in the Health Services Department. (100% Senior Nutrition Program Funds)   C. 52 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21101 to add one Clerk-Specialist (represented) position and cancel one Senior Legal Coordinator (represented) position in the County Counsel's Office. (Cost Savings)   C. 53 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21106 to establish the class of Executive Assistant I To The County Administrator- Exempt (unrepresented); and add one  Executive Assistant I To The County Administrator - Exempt (unrepresented) position in the office of the County Administrator/Clerk of the Board (Budgeted). INTRODUCE Ordinance No. 2012-08 to establish the class of Executive Assistant I To The County Administrator - Exempt in the County Administrator's office, waive reading, and fix July 24, 2012 for adoption.   C. 54 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21104 to increase the hours of one Registered Nurse- Experienced Level position (represented) in the Health Services Department. (100% CCHP Enterprise Fund III offset by reduction in straight time overtime)   C. 55 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21109 to add one (1) Administrative Services Assistant III (APTA)(represented) full-time position and cancel one (1) Personnel Services Assistant III (ARTA) (unrepresented) full-time position in the Office of the Sheriff. (No increased cost) (All Districts)   C. 56 ADOPT Position Adjustment Resolution No.21107, to add one Quality Management Program Coordinator (represented) position and cancel one Utilization Review Coordinator position (represented) in the Health Services Department. (100% Enterprise I)   C. 57 ADOPT Resolution Number 2012/300 to close the Bella Monte Child Care Cener effective close of business on June 30, 2012, and abolish positions and layoff employees effective close of business on July 13, 2012 in the Employment and Human Services Department, Community Services Bureau, as recommended by the Employment and Human Service Interim Director.  (Cost Savings)   C. 58 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21108 to cancel one Social Worker (represented) position and add one Social Work Supervisor II (represented) position in the Public Defender's Office.  (100% AB109 Public Safety Realignment funding)   Grants & Contracts  June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 12   APPROVE and AUTHORIZE execution of agreements between the County and the following agencies for receipt of fund and/or services:   C. 59 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with the State of California Department of Fish & Game, to pay the County $10,000 for the County’s Hazardous Materials Program participation in the Local Government Oil Spill contingency plan, for the period from July 1, 2012 through June 30, 2013. (No County match)   C. 60 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Department Interim Director, or designee, to amend a contract with the U.S. Department of Labor, Senior Service America, to increase the amount payable to the County by $175,000 to a new total not to exceed $802,700, to provide services to support older workers in obtaining and maintaining employment, and extend the expiration date from June 30, 2012 to September 30, 2012. (No County match)   C. 61 ADOPT Resolution 2012/269 to approve and authorize the District Attorney to submit an application and execute a grant award agreement, and any extensions or amendments thereof, pursuant to State guidelines, with the State Department of Insurance for funding of the Automobile Insurance Fraud Prosecution Program in the amount of $648,258 for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (100% State funds, no County match)   C. 62 ADOPT Resolution No. 2012/270 to approve and authorize the District Attorney to submit an application and execute a grant award agreement, and any extensions or amendments thereof, pursuant to State guidelines, with the California Department of Insurance Fraud Division for funding of the Disability and Heathcare Insurance Fraud Prosecution Program in the amount of $29,261 for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (100% State funds, no County match)   C. 63 APPROVE a change in ownership of the Rumrill Place apartments at 1883 Rumrill Boulevard in San Pablo and subordinate an existing $90,000 Community Development Block Grant program loan and $515,000 HOME Investment Partnerships Act loan, as recommended by the Conservation and Development Director.   C. 64 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract from Department of Housing and Urban Development to pay the County an amount not to exceed $501,273, for the Project Coming Home Addressing Addiction to Alcohol Program, for the period from June 1, 2012 through May 31, 2013. (No County match)   C. 65 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 13 C. 65 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Mount Diablo Unified School District to pay the County an amount not to exceed $983,111 to provide professional school-based mental health services, crisis intervention, and day treatment services for certain special education and regular students for the period July 1, 2011 through June 30, 2012. (No County match)   C. 66 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with the United States Department of Housing and Urban Developmentto receive Mckinney-Vento funding, payable to the County in an amount not to exceed $283,096, and execute a contract with HUD to perform all responsibilities in relation to receipt of the funding and contracted provisions for the operations of the FERST multi-service centers, during fiscal year 2012-2013. (No County match)   C. 67 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract from the United States Department of Housing and Urban Development to receive McKinney-Vento funding, payable to the County in an amount not to exceed $173,377, for the Permanent Connections Supportive Housing Program, for the period from July 1, 2012 through June 30, 2013. (No County match)   C. 68 APPROVE and AUTHORIZE County Counsel or her designee to execute on behalf of the County a form acknowledging a potential conflict of interest and consenting to Goldfarb & Lipman representing Lao Park Housing Corporation in connection with the refinancing of the Rumrill affordable housing project.   C. 69 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or his designee, to execute a contract with Public Health Foundation Enterprises, Inc., to pay the County an amount not to exceed $29,626, for continuation of the Centers for Disease Control and Prevention’s Emerging Infections Program - Retail Foods Project, January 1, 2012 through December 31, 2012. (No County match)   C. 70 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Public Health Foundation Enterprises, Inc., to pay the County an amount not to exceed $24,715 for the Public Health Laboratory Influenza Surveillance Project, for the period from January 1, 2012 through December 31, 2012. (No County match required)   C. 71 APPROVE and AUTHORIZE the Employment & Human Services Department Interim Director, or designee, to execute a contract to accept funding from California Department of Education in an amount not to exceed $611,465 to support childcare and development programs for the term July 1, 2012 through June 30, 2013.  (No County match)   C. 72 APPROVE and AUTHORIZE the Employment & Human Services Department June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 14 C. 72 APPROVE and AUTHORIZE the Employment & Human Services Department Interim Director, or designee, to execute a contract to accept funding from California Department of Education in an amount not to exceed $1,958,794 to support CalWORKS Stage 2 childcare and development programs for the term July 1, 2012 through June 30, 2013.  (No County match)   C. 73 APPROVE and AUTHORIZE the Employment & Human Services Interim Director, or designee, to amend a contract with Contra Costa Community College District, to change the minimum days of operation from 245 days to 251 days for state preschool services, with no change to the payment limit of $1,153,796 or term July 1, 2011 through June 30, 2012.   (No County match)   C. 74 APPROVE and AUTHORIZE the Sheriff-Coroner, or designee, to execute a contract amendment with Global Tel*Link Corporation to increase the duration of data storage from 60 to 180 days, with no change to the contract term or revenue payable to the County of up to $4,200,000. (No additional fiscal impact)   C. 75 APPROVE and AUTHORIZE the Employment & Human Services Department Interim Director, or designee, to execute a contract amendment with California Department of Education to change the minimum days of operation from 245 days to 251 days for childcare and development programs (CalWORKS Stage 2) with no change to the payment limit of $3,003,101 or term July 1, 2011 through June 30, 2012.   (No County match)   APPROVE and AUTHORIZE execution of agreement between the County and the following parties as noted for the purchase of equipment and/or services:   C. 76 APPROVE and AUTHORIZE the Agricultural Commissioner, or his designee, to execute Agreement #12-73-06-0251-RA with the United States Department of Agriculture (USDA) Wildlife Services in an amount not to exceed $28,323 for wildlife damage management, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013, as recommended by the the Agricultural Commissioner-Director of Weights and Measures. (60% Unclaimed Gas Tax, 40% County General Fund)   C. 77 APPROVE and AUTHORIZE the County Librarian, or designee, to execute a contract with 3M Library Systems in an amount not to exceed $155,745 for service and maintenance of SelfCheck machines, security gates, Radio Frequency Identification (RFID) workstations, RFID Digital Library Assistant and staff check-in machines for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Library Fund)   C. 78 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 15 C. 78 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with the Contra Costa Child Care Council to provide child care subsidies in the amount of $250,000 for the period of July 1, 2012 through June 30, 2013 and ACCEPT a report on the current status of the Child Care Affordability Funds, as recommended by the Family and Human Services Committee.  (100% Child Care Affordability Trust Fund)   C. 79 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Pittsburg Unified School District, effective September 1, 2012, to add Martin Luther King Jr. Junior High School as a location for provision of Teenage Pregnancy Project services, with no change in the original contract payment limit of $100,000 and no change in the original term of September 1, 2010 through August 31, 2015. (100% Federal Department of Health and Human Services)   C. 80 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a novation contract with Public Health Foundation Enterprises, Inc. (dba PHFE Management Solutions), in an amount not to exceed $141,440, to provide coordination, supervision, and support to County’s Senior Nutrition Program, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013, including a three-month automatic extension through September 30, 2013, in an amount not to exceed $35,360. (73% Federal Title III C (1) of the Older Americans Act of 1965, 27% Federal Title III C (2) of the Older Americans Act of 1965)   C. 81 APPROVE and AUTHORIZE the Conservation and Development Director, or designee, to execute a contract amendment with the City of Richmond, to increase the payment limit by $596,464 from $1,560,860 to $2,157,324 for assistance staffing the North Richmond Mitigation Fee Committee and jointly administering the implementation of City/County approved Expenditure Plans and extend the term from June 30, 2012 to September 30, 2013. (100% North Richmond Waste & Recovery Mitigation Fees)   C. 82 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Health Services Department, to execute a purchase order with Complete Imaging Systems, Inc., in an amount not to exceed $600,000, for fax and copier supplies and repairs throughout the Health Services Department, for the period of July 1, 2012 through June 30, 2014. (100% Enterprise Fund I)   C. 83 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with the Child Abuse Prevention Council of Contra Costa as recommended by the Family and Children's Trust Committee in an amount not to exceed $123,500 for the Nurturing Parenting Program and Baby Bag Project for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (40% County, 60 % State)   C. 84 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 16 C. 84 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Bay Area Tumor Institute, effective April 1, 2012, to increase the payment limit by $150,000 to a new payment limit of $650,000 to provide additional pharmaceutical drug recovery services with no change in the original term of August 1, 2011 through July 31, 2012. (100% contingency from savings)   C. 85 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a contract with Precision Paint & Collision, in an amount not to exceed $600,000, for automotive body damage repair and related mechanical repair work for the period June 1, 2012 through May 30, 2015. (100% Fleet Internal Services Fund)   C. 86 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee to execute a contract with Walker's Auto Body, in an amount not to exceed $200,000, for automotive body damage repair services, paint and related mechanical repair work, for the period June 1, 2012 through May 30, 2015. (100% Fleet Internal Services Fund)   C. 87 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with the Regents of the University of California, Davis, in an amount not to exceed $323,323, including modified indemnification language, to provide child welfare, eligibility, and community service training for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (16% State; 84% Federal)   C. 88 APPROVE and AUTHORIZE the County Administrator, or designee, to enter into a contract with the Contra Costa County Historical Society in an amount not to exceed $199,093 for continued support of the preservation and indexing of historical County records for the period July 1, 2012 through June 30, 2017. (100% General Fund)     C. 89 APPROVE and AUTHORIZE the Chief Engineer, Flood Control and Water Conservation District, or designee, on behalf of the Contra Costa Clean Water Program, to execute a Contract Amendment with Dan Cloak Environmental Consulting, to increase the payment limit by $120,000, for a new total contract amount not to exceed $245,000,  for continuing National Pollution Discharge Elimination System Compliance Assistance mandated by the Municipal Regional Permits issued by the San Francisco Bay and Central Valley Regional Water Quality Control Boards, for the period July 1, 2012, through June 30, 2013, Countywide.  (100% Cities and County Stormwater Utility Fee Assessments)   C. 90 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 17 C. 90 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Nancy E. Ebbert, M.D., in an amount not to exceed $294,000, to provide outpatient psychiatric services, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Mental Health Services Act)   C. 91 APPROVE and AUTHORIZE the Sheriff-Coroner, or designee, to execute a contract with StarFire Development, Inc., in an amount not to exceed $850,000 to provide consulting, design, development, and programming services for the Automated Regional Information Exchange System (ARIES) Project for the period April 1 through December 31, 2012. (100% User Agency fees, Budgeted)   C. 92 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a Consulting Services Agreement with Kitchell CEM in an amount not to exceed $360,000 to provide construction management services for the New Martinez Wellness Center and New Crisis Residential Facility projects. (100% Hospital Enterprise 1 Fund)   C. 93 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with STAND! For Families Free of Violence, in an amount not to exceed $162,690 to provide shelter services for battered women and their children for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (29% County; 71% Marriage License Fee)   C. 94 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a three-year Interagency Agreement with the Bethel Island Municipal Improvement District, in the amount of $49,500, to assist the County Watershed Program with implementation of the National Pollutant Discharge Elimination System requirements on Bethel Island, for the period beginning July 1, 2012 through June 30, 2015, Bethel Island area. (100% Stormwater Utility Assessment Revenue Funds)   C. 95 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a contract amendment, with Summit Building Services, to increase the payment limit by $385,000 to a new payment limit of $1,200,000, for remote building custodial services with no change to the contract term. (100% General Fund-Facilities Maintenance Budget)   C. 96 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Anka Behavioral Health, Inc., effective June 1, 2012, to increase the payment limit by $65,000, to a new payment limit of $833,690, to provide an additional level of services to include Behavioral Health Adult Court Collaborative services, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012, and to increase the automatic extension payment limit by $32,500, to a new payment limit of $416,845, through December 31, 2012. (49% Federal Medi-Cal, 43% State Mental Health Services Act, 8% State Substance Abuse/Mental Health Services Grant) June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 18   C. 97 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Center for Human Development, effective April 1, 2012, to increase the payment limit by $40,000 to a new payment limit of $369,638 to provide additional health education and outreach services to additional residents, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012. (5% Medi-Cal Administration Activities, 8% Enterprise I Funds, and 8% Kaiser Foundation Grant.)   C. 98 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with The Wright Institute, in an amount not to exceed $600,000, to provide behavioral health services at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, for the period July 1, 2012 through June 30 2014. (100% Enterprise Fund I)   C. 99 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Clarity Software Solutions, Inc., in an amount not to exceed $2,500,000, to provide professional printing, publication, distribution and technical assistance with regard to Contra Costa Health Plan member materials, for the period July 1, 2012 through June 30, 2015. (100% CCHP Member Premiums)   C.100 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Compass Group USA, Inc. (dba Compass Group Foodservice), in an amount not to exceed $2,283,814, to provide meal services for County’s Senior Nutrition Program for the period July 1, 2012 through June 30, 2013, with a three-month automatic extension through September 30, 2013, in an amount not to exceed $570,705. (100% Title III C-1 and Title III C-2 of the Federal Older Americans Act of 1965)   C.101 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with East Bay Nephrology Medical Group, Inc., in an amount not to exceed $156,000, to provide nephrology services at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, for the period July 1, 2012 through June 30, 2015. (100% Enterprise Fund I)   C.102 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with On Assignment Staffing Services, Inc., in an amount not to exceed $6,307,600 to provide temporary nursing staff, therapists, admitting professionals and other technical services, for the period June 1, 2012 through May 31, 2013. (100% Enterprise Fund I)   C.103 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Asian Community Mental Health Board (dba Asian Community Mental Health Services) in an amount not to exceed $150,000, to provide interpretation services to mental health patients in West Contra Costa County, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Mental Health Realignment)   June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 19   C.104 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Foley & Lardner, LLP, in an amount not to exceed $400,000, for the provision of temporary legal services with regard to Medi-Cal audit appeals and other health plan appeals, report issues, and authorized litigation issues, for the period from July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% by Enterprise I Funds)   C.105 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Beacon Partners, Inc., with no change in the payment limit of $1,200,800, to continue providing professional consultation and technical assistance with regard to project analysis and clinicial applications at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, to extend the term from July 31, 2012 through July 31, 2013. (100% Medicare and Medicaid Electronic Health Records Incentive Program of the American Recovery and Reinvestment Act and Delivery System Reform and Incentive Pool funding)   C.106 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Specialty Laboratories, Inc. (dba Quest Diagnostics Nichols Institute of Valencia), effective August 1, 2011, to increase the payment limit by $57,000 to a new payment limit of $657,000, to provide additional outside clinical laboratory services for Contra Costa Regional Medical and Health Centers, with no change in the original term of January 1, 2011 through December 31, 2011. (100% Enterprise Fund I)   C.107 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Cardinal Health Pharmacy Services, LLC, in an amount not to exceed $685,000, to provide remote order entry services of physician medication orders at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, for the period June 1, 2012 through May 31, 2013. (100% Enterprise Fund I)   C.108 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Nurse Family Partnership, in an amount not to exceed $140,000, to implement a Nurse-Family Partnership Program to provide home visits for first time mothers in Contra Costa County, for the period June 1, 2012 through June 30, 2015. (100% State Funds)   C.109 APPROVE and AUTHORIZE the Clerk-Recorder, or designee, to execute a contract amendment with DFM Associates, to increase the payment limit by $311,056 to continue providing software lease agreement for the election management system, and extend the term from July 1, 2012 through June 30, 2014. (100% General Fund, Budgeted)   C.110 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Health June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 20 C.110 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Health Services Department, to execute a purchase order with Universal Hospital Services, Inc., in an amount not to exceed $250,000, for rental of laser equipment, including accessories and delivery, for surgeries at Contra Costa Regional Medical and Health Centers, for the period from April 1, 2012 through March 31, 2014. (100% Enterprise Fund I)   C.111 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Health Services Department, to execute a purchase order with Henry Schein, Inc., in the amount of $300,000, for dental supplies, equipment and repairs at Contra Costa Regional Medical and  Health Centers, for the period from May 1, 2012 through April 30, 2014. (100% Enterprise Fund I)   C.112 APPROVE and AUTHORIZE the Clerk-Recorder, or designee, to execute a contract amendment with Election Systems & Software, LLC in an amount not to exceed $525,525 to a new payment limit of $1,050,260 to continue providing hardware and software maintenance services and support, and extend the term from January 1, 2013 through December 31, 2014. (100% General fund)   C.113 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Health Services Department, to execute a purchase order amendment with Laserband, LLC, to increase the payment limit by $300,000 for a new total payment limit of $460,000, for patient labeling and wristband sheets for Contra Costa Regional Medical and Health Centers, for the period from June 5, 2011 through June 4, 2013. (100% Enterprise Fund)   C.114 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Alternative Family Services, Inc., effective May 1, 2012, to increase the payment limit by $100,000 to a new payment limit of $600,000 to provide additional Multidimensional Treatment Foster Care services to Seriously Emotionally Disturbed youth, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012, and to increase the automatic extension payment limit by $50,000 to a new payment limit of $300,000, with no change in the term of the automatic extension, through December 31, 2012. (50% Federal Financial Participation and 50% State Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment)   C.115 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Youth Homes Incorporated, effective May 1, 2012, to increase the payment limit by $98,892 to a new payment limit of $1,808,892 to provide additional residential day treatment services, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012, and to increase the automatic extension payment limit by $49,446 to a new payment limit of $904,446, with no change in the term of the automatic extension, through December 31, 2012. (50% Federal Financial Participation and 50% State Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment)   C.116 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 21 C.116 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Laura Swafford, effective February 1, 2012, to increase the payment limit by $70,000 to a new payment limit of $145,000 to provide additional hours of consultation and technical assistance to the Department with regard to Keane Patcom System and the Epic Electronic Health Records Project, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012. (100% Enterprise I Budget.)   C.117 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of Health Services Department, to execute a purchase order amendment with Alere, Inc., to increase the payment limit by $125,000 for a new total of $223,000,  for the period from August 15, 2011 through August 14, 2012; and execute a new purchase order with Alere, Inc., in the amount of $360,000, for the period from August 15, 2012 through August 14, 2013, for reagents, controls, test kits calibrators needed to perform Brain Natriuretic Peptide tests at Contra Costa Regional Medical Center and Contra Costa Health Centers. (100% Enterprise Fund I)   C.118 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, on behalf of the Health Services Department, to execute a purchase order with Decade Software Company LLC, in an amount not to exceed $108,444, for software and licenses for the Envision Data System for the Enviromental Health and Hazardous Materials Divisions, for the period from May 1, 2012 through April 30, 2013. (100% Environmental Health and Hazardous Materials Program regulatory fees)   C.119 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with FamiliesFirst, Inc., effective May 1, 2012, to increase the payment limit by $88,464 to a new payment limit of $720,000 to provide additional intensive day treatment services, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012, and to increase the automatic extension payment limit by $44,232 to a new payment limit of $360,000, with no change in the term of the automatic extension, through December 31, 2012. (50% Federal Financial Participation and 50% State Early and Periodic, Screening, Diagnosis, and Treatment)   C.120 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Asereth Medical Services, Inc., in an amount not to exceed $210,000 to continue to provide temporary pharmacist coverage at Contra Costa Regional Medical Center, for the period from April 1, 2012 through March 31, 2013. (100% Enterprise Fund I)   C.121 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with the County of Santa Clara, effective March 1, 2012, to increase the payment limit by $55,000 to a new payment limit of $150,000 to provide additional inpatient mental health services for Contra Costa County inmates at Santa Clara County jail, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012. (100% Enterprise Fund I) June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 22   C.122 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Mental Health Management I, Inc. (dba Canyon Manor), effective April 1, 2012, to increase the payment limit by $38,016 to a new payment limit of $137,844 to provide additional mental health sub-acute care and treatment services, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012, and to increase the automatic extension payment limit by $50,734 to a new payment limit of $100,648, with no change in the term of the automatic extension, through December 31, 2012. (100% Mental Health Realignment)   C.123 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with Contra Costa Senior Legal Services, in an amount not to exceed $109,851 to provide countywide legal services to eligible clients, 60 years of age and older, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (100% Federal)   C.124 APPROVE and AUTHORIZE the Director of Child Support Services, or designee, to execute a contract with Integrated Information Systems, Inc. in an amount not to exceed $99,180, for updates to the TurboCourt system for the period of June 1, 2012 through June 30, 2012. (66% Federal, 34% State)   C.125 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with Family Caregiver Alliance, in an amount not to exceed $138,634 for Older American’s Act, Title III-E Family Caregiver Provider Program services in support of older adults and their caregivers and families for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (100% Federal)   C.126 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with Community Violence Solutions, Inc., in an amount not to exceed $110,000 for the operation of the Children’s Interview Center for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (32% Local Law Enforcement Agencies, 2% County, 42% Federal, 24% State)   C.127 APPROVE and AUTHORIZE the Sheriff-Coroner, or designee, to execute a contract with John Meyers in an amount not to exceed $300,000 for helicopter pilot services for the period July 1, 2012 through June 30, 2014. (No impact to the General Fund; user fees, state and grant funds; budgeted)   C.128 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with the In-Home Supportive Services (IHSS) Public Authority in an amount not to exceed $1,758,923 to provide IHSS program services for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (17% County, 33% State, 50% Federal)   June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 23   C.129 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with Chabot - Las Positas Community College District in an amount not to exceed $250,000, to provide training and technical assistance to staff and assessment proctoring services to job seekers, for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Federal)   C.130 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Robert Half International, Inc., effective October 1, 2011, to increase the payment limit by $250,000, to a new total payment limit of $1,250,000, to provide reimbursement for travel and miscellaneous expenses incurred in providing specialized consulting and computer programming support to Department’s Health Services Information Technology Division, and to extend the term of the Contract from June 30, 2012 through December 31, 2012. (100% American Recovery & Reinvestment Act).   C.131 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with the Oakland Private Industry Council, including mutual indemnification, in an amount not to exceed $610,000, to provide training vendor and pay agent services for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (100% Federal)   C.132 APPROVE and AUTHORIZE the  Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with Henkels & McCoy, Inc., in an amount not to exceed $800,000 for Workforce Investment Act Out-of-school Youth Services for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Federal)   C.133 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with Seneca Family of Agencies, in an amount not to exceed $360,000, to provide wraparound program services for youth, for the period August 1, 2012 to July 31, 2013.  (40% State, 60% County)   C.134 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with the Contra Costa County Office of Education in an amount not to exceed $800,000, for Workforce Investment Act In-School Youth Services for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (100% Federal)   C.135 AUTHORIZE the Sheriff-Coroner to continue the departmental employee service awards program;  and APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent to execute, on behalf of the Sheriff-Coroner, purchase order amendment with O.C. Tanner Company, to increase the payment limit by $25,000 to a new payment limit of $50,000 and extend the termination date to June 30, 2014 for employee appreciation awards. (100% County General Fund, budgeted)   C.136 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 24 C.136 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Interim Director, or designee, to execute a contract with Ombudsman Services of Contra Costa in an amount not to exceed $197,665, to provide long term care ombudsman services to seniors for the period July 1, 2012 through June 30, 2013.  (100% Federal)   Other Actions   C.137 DECLARE as surplus and authorize the Purchasing Agent, or designee, to dispose of fully depreciated vehicles no longer needed for public use as recommended by the Public Works Director. (No fiscal impact)   C.138 ADOPT Resolution No. 2012/261 establishing a triennial review process for the evaluation of certain county boards, committees and commissions, as recommended by the Internal Operations Committee.   C.139 ACCEPT the Treasurer’s Investment Report as of March 31, 2011 as recommended by the County Treasurer-Tax Collector.   C.140 ACCEPT the Treasurer’s Investment Policy for the Fiscal Year 2012-2013 as revised and adopted by the Treasury Oversight Committee.   C.141 APPROVE the Amended 2012/2013 North Richmond Waste and Recovery Mitigation Fee Expenditure Plan and AUTHORIZE execution of "Amendment No. 2 to the Memorandum of Understanding by and between the City of Richmond and the County of Contra Costa regarding Solid Waste Transfer Facility Host Community Mitigation Fees”, as requested by the North Richmond Waste and Recovery Mitigation Fee Joint Expenditure Planning Committee. (100% North Richmond Mitigation Fees)   C.142 APPROVE a Settlement and Property Transfer Agreement and Release of Claims and Joint Exercise of Powers Agreement for the Transfer of Funds for Maintenance of Bay Point Parks with, and conveyance of five Bay Point area parks to, the Ambrose Recreation and Park District, and make related findings under the California Environmental Quality Act (CEQA), Bay Point area, as recommended by the Public Works Director. (100% Quimby Fee (Park Dedication) Funds)   C.143 APPROVE the Notice of Intention to Purchase Real Property located at 211 C Street, Martinez, APN 372-191-011, for the sum of $252,500, as recommended by the Public Works Director. Martinez area (100% Enterprise Fund I revenues).     C.144 ADOPT Resolution No. 2012/286 establishing corrected appropriation limits for the County Service Areas and County Special Districts for Fiscal Year 2012/13, as recommended by the Auditor-Controller.   June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 25 C.145 APPROVE the Temporary Permit to Use Property with Martinez Unified School District (MUSD) in the amount of $9,720, effective June 27, 2012 through July 22, 2012, for implementation of the Health Services EPIC computerized health records program, Martinez area. (100% Hospital Enterprise Fund I)   C.146 REFER to the Internal Operations Committee the proposal to develop a draft policy and guidelines for use of social media tools by County departments. (No fiscal impact)   C.147 REFER to the Internal Operations Committee the review and updating of the CCTV Operations Policy and Procedures reflecting changes in the Public/Education/Government cable television landscape. (No fiscal impact)   C.148 ACCEPT the May 2012 update on the operations of the Employment and Human Services Department, Community Services Bureau, as recommended by the Employment and Human Services Interim Director.   C.149 APPROVE the proposed changes to the Medical Staff Bylaws and Rules & Regulations, as recommended by the Medical Executive Committee, the Joint Conference Committee, and the Health Services Director.   C.150 APPROVE new medical staff members, staff affiliations, advancements to permanent staff, privileges, changes to ultrasound privileges, secondary department membership, biennial reappointments, and resignations, as recommended by the Medical Executive Committee at their May 21, 2012 meeting, and by the Health Services Director.   C.151 ACCEPT the Fiscal Year 2012-2013 Mental Health Services Act (Proposition 63) Annual Plan Update from the Health Services Department as recommended by the Acting Mental Health Director.   C.152 AUTHORIZE a “yes” vote for County owned parcel located at 1305 Macdonald Avenue, APN 540-082-033, for the Downtown Richmond Property and Business Improvement District Fee election and DIRECT the Public Works Director, or designee, to sign and submit the ballot, Richmond area. (Karen Laws, Public Works Department)   C.153 CORRECT the Board Order which was approved by the Board of Supervisors on June 5, 2012, Agenda Item (C.96), to amend a contract with Bi-Bett, effective March 1, 2012, to correct the increase in the payment limit to read $574,273, instead of $571,273, for a new total of $2,266,773, and to correct the increase in the automatic extension amount to read $264,089, instead of $723,591, for a new total of $1,110,339, with no change in the original term of July 1, 2011 through June 30, 2012. (72% Federal, 18% State, 8% AB109 Revenue; and 2% Substance Abuse Prevention and Treatment Funds)   C.154 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or his designee, to June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 26 C.154 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or his designee, to execute an agreement between the City of Concord and a group of homeless service providers, including the County, in connection with land transfers and the development and operation of housing units for homeless persons on portions of the former Concord Naval Weapons Station, as recommended by the Health Services Director.  (No fiscal impact)   C.155 ACCEPT the annual report from the Local Child Care Planning & Development Council on their activities, as recommended by the Family and Human Services Committee.  (No fiscal impact)   C.156 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent to execute, on behalf of the Sheriff-Coroner, a purchase order with Downtown Ford in the amount of $100,500 for four 2013 Ford Escape Utility Vehicles for the Patrol Division.  (Consider with C. 44)   C.157 RECEIVE Civil Grand Jury Report No. 1211, entitled "Contra Costa County Fire Protection and Emergency Response Services, Leveraging Combined Strengths to Address Individual Weaknesses," and REFER to the County Administrator for response, as recommended by the County Administrator.   C.158 RECEIVE Civil Grand Jury Report No. 1215, entitled "Help Wanted - Appointed Bodies," and REFER to the County Administrator for response, as recommended by the County Administrator.   C.159 ADOPT Resolution No. 2012/287 authorizing the issuance of Multi-Family Housing Revenue Bonds in an amount not to exceed $18 million to finance the development of Berrellesa Palms, Martinez. (No fiscal impact)   C.160 CONTINUE the emergency action originally taken by the Board of Supervisors on November 16, 1999 regarding the issue of homelessness in Contra Costa County, as recommended by the Health Services Director.   Successor Agency to the Contra Costa County Redevelopment Agency   C.161 ADOPT Resolution No. 2012/299, by the Board of Supervisors acting as the Contra Costa County Redevelopment Successor Agency, amending the January to June 2012 Recognized Obligation Payment Schedule, as recommended by the Conservation and Development Director.   GENERAL INFORMATION The Board meets in all its capacities pursuant to Ordinance Code Section 24-2.402, including as the Housing Authority and the Successor Agency to the Redevelopment Agency. Persons who wish to address the Board should complete the form provided for that purpose and furnish a copy of any written statement to the Clerk. Any disclosable public records related to an open session item on a regular meeting agenda and June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 27 distributed by the Clerk of the Board to a majority of the members of the Board of Supervisors less than 72 hours prior to that meeting are available for public inspection at 651 Pine Street, First Floor, Room 106, Martinez, CA 94553, during normal business hours. All matters listed under CONSENT ITEMS are considered by the Board to be routine and will be enacted by one motion. There will be no separate discussion of these items unless requested by a member of the Board or a member of the public prior to the time the Board votes on the motion to adopt.  Persons who wish to speak on matters set for PUBLIC HEARINGS will be heard when the Chair calls for comments from those persons who are in support thereof or in opposition thereto. After persons have spoken, the hearing is closed and the matter is subject to discussion and action by the Board.  Comments on matters listed on the agenda or otherwise within the purview of the Board of Supervisors can be submitted to the office of the Clerk of the Board via mail: Board of Supervisors, 651 Pine Street Room 106, Martinez, CA 94553; by fax: 925-335-1913. The County will provide reasonable accommodations for persons with disabilities planning to attend Board meetings who contact the Clerk of the Board at least 24 hours before the meeting, at (925) 335-1900; TDD (925) 335-1915. An assistive listening device is available from the Clerk, Room 106. Copies of recordings of all or portions of a Board meeting may be purchased from the Clerk of the Board.  Please telephone the Office of the Clerk of the Board, (925) 335-1900, to make the necessary arrangements.   Forms are available to anyone desiring to submit an inspirational thought nomination for inclusion on the Board Agenda. Forms may be obtained at the Office of the County Administrator or Office of the Clerk of the Board, 651 Pine Street, Martinez, California. Applications for personal subscriptions to the weekly Board Agenda may be obtained by calling the Office of the Clerk of the Board, (925) 335-1900. The weekly agenda may also be viewed on the County’s Internet Web Page:  www.co.contra-costa.ca.us    STANDING COMMITTEES The Airport Committee (Supervisors Mary N. Piepho and Karen Mitchoff) meets on the fourth Monday of the month at 12:30 p.m. at Director of Airports Office, 550 Sally Ride Drive, Concord. The Family and Human Services Committee (Supervisor Federal D. Glover) meets on the first Monday of the month at 1:30 p.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Finance Committee (Supervisors John Gioia and Federal D. Glover) meets on the second Monday of the month at 1:30 p.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street,June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 28 Monday of the month at 1:30 p.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Internal Operations Committee (Supervisor Mitchoff) meets on the second Monday of the month at 9:00 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Legislation Committee (Supervisors Mary N. Piepho and Karen Mitchoff) meets on the first Thursday of the month at 10:30 a.m. in Room 108, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Public Protection Committee (Supervisor Federal D. Glover) meets on the first Monday of the month at 11:00 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Transportation, Water & Infrastructure Committee (Supervisors Mary N. Piepho and Federal D. Glover) meets on the first Thursday of the month at 9:30 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez.   Airports Committee  July 23. 2012  12:30 PM See above Family & Human Services Committee  Canceled  Canceled See above Finance Committee  July 9, 2012  12:30 PM See above Internal Operations Committee  July 9, 2012  9:00 AM See above Legislation Committee  July 25, 2012  10:30 AM See above Public Protection Committee  Canceled  Canceled See above Transportation, Water & Infrastructure Committee  July 5, 2012  1:30 PM See above   PERSONS WHO WISH TO ADDRESS THE BOARD MAY BE LIMITED TO THREE (3) MINUTES AGENDA DEADLINE: Thursday, 12 noon, 12 days before the Tuesday Board meetings. Glossary of Acronyms, Abbreviations, and other Terms (in alphabetical order): Contra Costa County has a policy of making limited use of acronyms, abbreviations, and industry-specific language in its Board of Supervisors meetings and written materials. Following is a list of commonly used language that may appear in oral presentations and written materials associated with Board meetings: AB Assembly Bill ABAG Association of Bay Area Governments ACA Assembly Constitutional Amendment ADA Americans with Disabilities Act of 1990 AFSCME  American Federation of State County and Municipal Employees AICP American Institute of Certified Planners AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome ALUC Airport Land Use Commission AOD  Alcohol and Other Drugs ARRA  American Recovery & Reinvestment Act of 2009 BAAQMD Bay Area Air Quality Management District BART Bay Area Rapid Transit District BayRICS Bay Area Regional Interoperable Communications System BCDC Bay Conservation & Development Commission BGO  Better Government Ordinance BOS Board of Supervisors CALTRANS  California Department of Transportation CalWIN California Works Information NetworkJune 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 29 CalWIN California Works Information Network CalWORKS California Work Opportunity and Responsibility to Kids CAER Community Awareness Emergency Response CAO  County Administrative Officer or Office CCCPFD (ConFire) Contra Costa County Fire Protection District CCHP Contra Costa Health Plan CCTA Contra Costa Transportation Authority CCRMC Contra Costa Regional Medical Center CCWD Contra Costa Water District CDBG Community Development Block Grant CFDA Catalog of Federal Domestic Assistance CEQA California Environmental Quality Act CIO Chief Information Officer COLA Cost of living adjustment ConFire (CCCFPD) Contra Costa County Fire Protection District CPA Certified Public Accountant CPI Consumer Price Index CSA County Service Area CSAC California State Association of Counties CTC California Transportation Commission dba doing business as EBMUD East Bay Municipal Utility District ECCFPD East Contra Costa Fire Protection District EIR Environmental Impact Report EIS Environmental Impact Statement EMCC Emergency Medical Care Committee EMS Emergency Medical Services EPSDT  Early State Periodic Screening, Diagnosis and Treatment Program (Mental Health) et al. et alii (and others) FAA Federal Aviation Administration FEMA  Federal Emergency Management Agency F&HS Family and Human Services Committee First 5 First Five Children and Families Commission (Proposition 10) FTE Full Time Equivalent FY Fiscal Year GHAD Geologic Hazard Abatement District GIS Geographic Information System HCD  (State Dept of) Housing & Community Development HHS (State Dept of ) Health and Human Services HIPAA  Health Insurance Portability and Accountability Act HIV Human Immunodeficiency Syndrome HOV High Occupancy Vehicle HR  Human Resources HUD  United States Department of Housing and Urban Development IHSS In-Home Supportive Services Inc. Incorporated IOC Internal Operations Committee ISO Industrial Safety Ordinance JPA Joint (exercise of) Powers Authority or Agreement Lamorinda Lafayette-Moraga-Orinda Area LAFCo  Local Agency Formation Commission LLC Limited Liability Company LLP Limited Liability Partnership Local 1 Public Employees Union Local 1 LVN Licensed Vocational Nurse MAC Municipal Advisory Council MBE Minority Business Enterprise M.D. Medical Doctor M.F.T. Marriage and Family Therapist MIS Management Information System MOE Maintenance of Effort MOU Memorandum of Understanding MTC Metropolitan Transportation Commission NACo National Association of Counties NEPA National Environmental Policy Act OB-GYN Obstetrics and Gynecology O.D. Doctor of Optometry OES-EOC  Office of Emergency Services-Emergency Operations Center OPEB Other Post Employment Benefits OSHA Occupational Safety and Health Administration PARS Public Agencies Retirement Services Psy.D. Doctor of Psychology RDA Redevelopment Agency RFI Request For Information RFP Request For Proposal RFQ Request For Qualifications RN Registered Nurse SB  Senate Bill SBE Small Business Enterprise SEIU Service Employees International Union SUASI  Super Urban Area Security Initiative SWAT  Southwest Area Transportation Committee TRANSPAC Transportation Partnership & Cooperation (Central) TRANSPLAN Transportation Planning Committee (East County) TRE or TTE Trustee TWIC Transportation, Water and Infrastructure Committee UASI  Urban Area Security Initiative VA Department of Veterans Affairs vs. versus (against) WAN Wide Area Network June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 30 WBE Women Business Enterprise WCCTAC West Contra Costa Transportation Advisory Committee June 26, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 31