Loading...
HomeMy WebLinkAboutAGENDA - 04242012 -               CALENDAR FOR THE BOARD OF SUPERVISORS CONTRA COSTA COUNTY AND FOR SPECIAL DISTRICTS, AGENCIES, AND AUTHORITIES GOVERNED BY THE BOARD BOARD CHAMBERS ROOM 107, ADMINISTRATION BUILDING, 651 PINE STREET MARTINEZ, CALIFORNIA 94553-1229 MARY N. PIEPHO, CHAIR, 3rd DISTRICT JOHN GIOIA, 1st DISTRICT GAYLE B. UILKEMA, 2nd DISTRICT KAREN MITCHOFF, 4th DISTRICT FEDERAL D. GLOVER, 5th DISTRICT DAVID J. TWA, CLERK OF THE BOARD AND COUNTY ADMINISTRATOR, (925) 335-1900 The Board of Supervisors respects your time, and every attempt is made to accurately estimate when an item may be heard by the Board. All times specified for items on the Board of Supervisors agenda are approximate. Items may be heard later than indicated depending on the business of the day. Your patience is appreciated. AGENDA April 24, 2012                  9:00 A.M.  Convene and adjourn to Closed Session in Room 101.    Closed Session Agenda : A. CONFERENCE WITH LABOR NEGOTIATORS 1. Agency Negotiators: David Twa and Ted Cwiek. Employee Organizations: Contra Costa County Employees’ Assn., Local No. 1; Am. Fed., State, County, & Mun. Empl., Locals 512 and 2700; Calif. Nurses Assn.; Service Empl. Int’l Union, Local1021; District Attorney’s Investigators Assn.; Deputy Sheriffs Assn.; United Prof. Firefighters, Local 1230; Physicians’ & Dentists’ Org. of Contra Costa; Western Council of Engineers; United Chief Officers Assn.; Service Empl. Int’l Union United Health Care Workers West; East County Firefighters’ Assn.; Contra Costa County Defenders Assn.; Probation Peace Officers Assn. of Contra Costa County; Contra Costa County Deputy District Attorneys’ Assn.; and Prof. & Tech. Engineers, Local 21, AFL-CIO. 2. Agency Negotiators: David Twa and Ted Cwiek. Unrepresented Employees: All unrepresented employees. B. CONFERENCE WITH LEGAL COUNSEL--EXISTING LITIGATION (Gov. Code, § 54956.9(a)) 1. C&H Sugar Company, Inc. et al. v. Crockett Community Services District, et al., Contra Costa Superior Court, Case No. N07-1747.   9:30 A.M.  Call to order and opening ceremonies.                    Inspirational Thought - “There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it." ~ Edith Wharton   April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 1 CONSIDER CONSENT ITEMS (Items listed as C.1 through C.86 on the following agenda) – Items are subject to removal from Consent Calendar by request of any Supervisor or on request for discussion by a member of the public.  Items removed from this section will be considered with the Short Discussion Items.   PRESENTATIONS   PR. 1 PRESENTATION to recognize the new Bay Area Green Businesses for 2012, as recommended by the Health Services Director.  (Paris Greenlee, Green Business Program)   PR. 2 PRESENTATION to honor the Assistance League of Diablo Valley on its 45th Anniversary as recommended by Supervisor Mitchoff. (See C. 25)   PR. 3     PRESENTATION to honor Nancy Baer for twenty-six years of service. (Wendel Brunner, M.D.) (See C. 24)          PR. 4     PRESENTATION to declare the month of April 2012 as "National Sexual Assault Awareness Month", as recommended by Supervisor Piepho. (See C. 26)   SHORT DISCUSSION ITEMS           SD. 1    PUBLIC COMMENT (3 Minutes/Speaker)           SD. 2     CONSIDER Consent Items previously removed.   SD. 3 CONSIDER including a loan provision in the County Deferred Compensation Plan and, if approved, DIRECT county staff to take the next steps to implement the loan provision, as recommended by the Internal Operations Committee. (Supervisor Mitchoff)   SD. 4 INITIATE a General Plan and Zoning Code Review to permit Urban Agriculture uses and activities within North Richmond as recommended by Supervisor Gioia.   DELIBERATION ITEMS   D. 1 HEARING on the Fiscal Year 2012/13 Recommended County and Special District Budgets.  (David Twa, County Administrator)           D. 2      CONSIDER reports of Board members.   Closed Session   1:00 P.M.   ADJOURN to the Contra Costa County Fire Protection District Meeting.   CONSENT ITEMSApril 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 2 CONSENT ITEMS   Road and Transportation   C. 1 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director to execute the Temporary Soil Testing and Surveys Permit for biological and archeological surveys with Charles Richey, TRE, Diane Richey, TRE, Charlesie Roberts Hunter, TRE, Melvin V. Hunter, TRE and Charles Erwin Richey, TRE, effective May 1, 2012 through December 31, 2012, for the Camino Tassajara Shoulder Widening 1.1 mi South of Highland Rd to Windermere Parkway Project, as recommended by the Public Works Director, San Ramon area. (60.5% South County Area of Benefit and 39.5% Highway Safety Improvements Program Funds)   C. 2 ADOPT Traffic Resolution No. 2012/4349 to prohibit parking at all times for vehicles 6 feet or more in height (including any load thereon), or 20 feet or more in length on the west side of Danville Boulevard (Road No. 5301A), beginning 370 feet south of the south curb line of Las Trampas Road (Road No. 4334A) and extending southerly a distance of 110 feet, as recommended by the Public Works Director, Alamo area. (No Fiscal Impact)   C. 3 ADOPT Resolution No. 2012/160 approving and authorizing the Public Works Director, or designee, to partially close a portion of Willow Pass Road (east bound lanes only) between Marin Avenue and Manor Drive, on May 28, 2012 from 9:00 A.M. through 11:00 A.M., for the purpose of a Memorial Day Parade, Bay Point area. (No Fiscal Impact)   C. 4 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute Amendment No. 1, effective January 30, 2012, to an existing Consulting Services Agreement with Ghirardelli Associates, Inc., to extend the termination date from January 31, 2012 through August 31, 2012, and to increase the current payment limit by $30,000 to a new payment of $148,104 in order to provide construction management services for the Countywide Arterial Micro-Surface Project, Countywide. (88.8% Federal CMA Block Grant – Local Streets and Roads Shortfall Program Funds, and 11.2% Measure J Funds)   C. 5 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute Amendment No. 2, effective March 1, 2012, to an existing Consulting Services Agreement with Ghirardelli Associates, Inc. to extend the termination date from March 1, 2012 to June 30, 2012 and increase the current payment limit by $10,000 to a new payment of $1,145,190 in order to provide construction management services for the Vasco Road Safety Improvements Project Phase 1, Brentwood and Byron areas. (100% Road funds)   Engineering Services   April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 3 C. 6 ADOPT Resolution No. 2012/152 accepting the completion of warranty period and release of cash deposit under the Road Improvement Agreement for Land Use Permit LP 08-02044, for a project being developed by Aventine Development Corporation, as recommended by the Public Works Director, Bay Point area.  (100% Developer Deposit)   C. 7 ADOPT Resolution No. 2012/150 approving the third extension of the Subdivision Agreement (Right-of-Way Landscaping) for Park Acceptance PA 05-00025 (cross-reference Subdivision SD 05-08957), for a project being developed by Windemere BLC Land Company, LLC, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (No Fiscal Impact)   C. 8 ADOPT Resolution No. 2012/153 accepting completion of improvements for Subdivision Agreement (Right-of-Way Landscaping) for Road Acceptance  RA 03-01152 (cross-reference Subdivision SD 99-08306), Stoneleaf Road for a project being developed by Shapell Industries of Northern California, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (100% Developer Deposit)   C. 9 ADOPT Resolution No. 2012/154 accepting completion of  improvements for Road Improvement Agreement for Stoneleaf Road for Road Acceptance RA 03-01152 (Cross-reference Subdivision SD 99-08306), for a project being developed by Shapell Industries of Northern California, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (100% Developer Deposit)   C. 10 ADOPT Resolution No. 2012/155 accepting completion of landscape improvements for Subdivision Agreement (Right-of-Way Landscaping) for Subdivision SD 05-08952, being developed by Shapell Homes, A Division of Shapell Industries, Inc., San Ramon (Dougherty Valley) area. (100% Developer Deposit)   C. 11 ADOPT Resolution No. 2012/156 approving the fourth extension of the Subdivision Agreement (Right-of-Way Landscaping) for Subdivision SD 05-09020, for project being developed by Windemere BLC Land Company, LLC, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (No Fiscal Impact)   C. 12 ADOPT Resolution No. 2012/157 approving the fourth extension of the Subdivision Agreement (Right-of-Way Landscaping) for Subdivision SD 05-09021, for project being developed by Windemere BLC Land Company, LLC, as recommended by the Public Works Director, San Ramon (Dougherty Valley) area. (No Fiscal Impact)   C. 13 ADOPT Resolution No. 2012/162 approving the fifth extension of the April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 4 C. 13 ADOPT Resolution No. 2012/162 approving the fifth extension of the Subdivision Agreement for Subdivision SD 89-07267, for a project being developed by Lafayette-King Drive Associates/Morgan Capital Investment Properties c/o Sequoia Land Investments, as recommended by the Public Works Director, Lafayette area. (No Fiscal Impact)   Special Districts & County Airports   C. 14 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a contract with Stantec Architecture Inc. effective April 1, 2012 to March 31, 2014, in an amount not to exceed $200,000, to provide landscape architect services, Countywide. (100% Special Revenue Funds)   C. 15 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a contract with Callander Associates Landscape Architecture, Inc. effective April 1, 2012 to March 31, 2014, in an amount not to exceed $200,000, to provide landscape architect services, Countywide. (100% Special Revenue Funds)   C. 16 ADOPT the Vasco Road Safety Improvement Project Addendum to the Mitigated Negative Declaration in compliance with the California Environmental Quality Act, as recommended by the Public Works Director, Byron area. (No Fiscal Impact)   C. 17 ADOPT Resolution No. 2012/151 accepting as complete the contracted work performed by Electronic Innovations, Inc., for the Buchanan Field Airport Security Upgrades project, as recommended by the Public Works Director, Concord area. (100% Federal FAA Airport Improvement Funds)   C. 18 APPROVE and AUTHORIZE the Airports Director, or designee, to submit Airport Improvement Program (AIP) grant applications to both the Federal Aviation Administration (FAA) and the California Department of Transportation-Division of Aeronautics (Caltrans) in the amount not to exceed $600,000 and $15,000, respectively, to perform pavement maintenance on all the airfield, perform minor reconstruction on a portion of the ramp, and upgrade signage and lighting at the Byron Airport; APPROVE and AUTHORIZE the Chair Board of Supervisors to sign a Statement of Acceptance of funds; and APPROVE and AUTHORIZE the Airports Director, or designee, to sign an acceptance of funds under the California Aid to Airports Program Grant Agreement-Federal AIP Matching Funds grand program. (90% FAA, 2.25% Caltrans, and 7.75% Airport Enterprise Funds)   Claims, Collections & Litigation   C. 19 DENY claims filed by Jordan Christensen, Michael Gressett, and Robert April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 5 C. 19 DENY claims filed by Jordan Christensen, Michael Gressett, and Robert Rodriguez; and, DENY applications to file late claim by Douglas Bolesch, Michael Gressett, and Kathryn Halbleib-Wood.   C. 20 RECEIVE report concerning the final settlement of Robert Crawford vs. Contra Costa County Fire Protection District; and AUTHORIZE payment from the Workers' Compensation Internal Service Fund in an amount not to exceed $30,000. (100% Workers' Compensation Internal Service Fund)   C. 21 RECEIVE report concerning the final settlement of Emilyn Russo vs. Contra Costa County Assessor's Office; and AUTHORIZE payment from the Workers' Compensation Internal Service Fund in an amount not to exceed $32,500, less permanent disability advances. (100% Workers' Compensation Internal Service Fund)   C. 22 RECEIVE report concerning the final settlement of Herrera v. Contra Costa County; and AUTHORIZE payment from the Medical Malpractice Internal Service Fund in an amount of $275,000. (100% Medical Malpractice Internal Service Fund)   Honors & Proclamations   C. 23 ADOPT Resolution No. 2012/178 honoring Ellen Beans as the Moraga 2012 Citizen of the Year, as recommended by Supervisor Uilkema.   C. 24 PRESENTATION to honor Nancy Baer for twenty-six years of service. (Wendel Brunner, M.D.) (See PR. 3)   C. 25 ADOPT Resolution No. 2012/130 honoring the Assistance League of Diablo Valley on its 45th Anniversary, as recommended by Supervisor Mitchoff. (See PR. 2)   C. 26 ADOPT Resolution No. 2012/172 declaring the month of April 2012 as National Sexual Assault Awareness Month, as recommended by Supervisor Piepho. (See PR. 4)   C. 27 ADOPT Resolution No. 2012/135 proclaiming May 10, 2012 as "Bike to Work" Day, and REQUEST County Department heads to participate in outreach efforts for Bike to Work Day for their employees, as recommended by the Conservation and Development Director, Countywide. (No fiscal impact)   C. 28 ADOPT Resolution No. 2012/132 honoring the Interfaith Council of Contra Costa County and Shri Guru Ravidass Sikh Temple on the occasion of their annual Diversity Spring Festival as recommended by Supervisor Mitchoff.   C. 29 ADOPT Resolution No. 2012/169 recognizing Aretha Chandler upon the April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 6 C. 29 ADOPT Resolution No. 2012/169 recognizing Aretha Chandler upon the occasion of her 20-year anniversary with the County, as recommended by the Risk Manager.   C. 30 ADOPT Resolution No. 2012/164 honoring Cynthia LeBlanc, National Chair of the American Cancer Society Board, as recommended by Supervisor Gioia.   C. 31 ADOPT Resolution No. 2012/166 honoring West County Reads for its Ten Years of Volunteer Service to Boost the Literacy Skills of all Children in West Contra Costa County, as recommended by Supervisor Gioia.   Ordinances   C. 32 ADOPT Ordinance 2012-01 amending Section 33-5.341 of the County Ordinance Code to re-title the classification of Chief Deputy Agricultural Commissioner/Sealer of Weights and Measures - Exempt to Assistant Agricultural Commissioner/Sealer of Weights and Measures - Exempt from the Merit System, as requested by the Agriculture Department.  (No Cost)   Appointments & Resignations   C. 33 REAPPOINT John F. Jones as District V Regular Position Representative of the First 5 Contra Costa Children and Families Commission, as recommended by Supervisor Glover.   C. 34 APPOINT Evelyn Centeno as the District V Member At Large Seat on the Contra Costa County Mental Health Commission, as recommended by Supervisor Glover.   C. 35 APPOINT Judy Carney to the District II Seat of the Contra Costa Commission for Women for a term with an expiration date of February 28, 2013, as recommended by Supervisor Uilkema.   C. 36 REAPPOINT Jo Ann Hirsch, Joseph Motta, Steve Nelson, Diane Barley, Barbara Cappa to the County Service Area P-2B Citizens Advisory Committee for two-year terms, as recommended by Supervisor Uilkema.   C. 37 REAPPOINT Leland Mlejnek, Robert Saydah and Brent Simor to the County Service Area P-5 Citizens Advisory Committee, each for a two-year term with an expiration date of December 31, 2013; APPOINT Michael A. Marchi to fulfill a vacated term with an expiration date of December 31, 2012, as recommended by Supervisor Uilkema.   C. 38 APPOINT Roberta Currier to the District IV seat on the Emergency Medical Care Commission as recommended by Supervisor Mitchoff.   C. 39 REAPPOINT Dan Hardin as the District V Seat 2 Representative on the Rodeo April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 7 C. 39 REAPPOINT Dan Hardin as the District V Seat 2 Representative on the Rodeo Municipal Advisory Council, as recommended by Supervisor Glover.   C. 40 REAPPOINT Marina G. Ramos as District V Seat 4 Representative on the Rodeo Municipal Advisory Council, as recommended by Supervisor Glover.   C. 41 APPOINT Anthony Hodge Jr. as the District V Seat 5 Representative on the Rodeo Municipal Advisory Council, as recommended by Supervisor Glover.   C. 42 REAPPOINT Mary C. Welles as the District V Seat 1 Representative on the County Service Area M-16 Citizens Advisory Committee, as recommended by Supervisor Glover.   C. 43 REAPPOINT Mary Kay Miller to the District II seat of the Family and Children's Trust Committee for a two-year term with an expiration date of September 30, 2013, as recommended by Supervisor Uilkema.   C. 44 REAPPOINT Larry Rodrigue to the Appointee 4 Seat of the County Service Area P-5 Citizens Advisory Committee; ACCEPT the resignation of Robert Besse from the 2nd Alternate Seat of the County Service Area P-5 Citizens Advisory Committee effective immediately and APPOINT Robert Besse to the 1st Alternate Seat of County Service Area P-5 Citizens Advisory Committee, as recommended by Supervisor Gayle B. Uilkema.   C. 45 ACCEPT the letter of resignation of Suzanne Board from the regular seat on the County Service Area R-10 Citizen Advisory Committee; DECLARE a vacancy; and Direct the Clerk of the Board to post the vacancy, as recommended by Supervisor Glover.   C. 46 ACCEPT resignation of Evelyn Javier Centeno from the District II Member at Large Seat of the Contra Costa County Mental Health Commission effective immediately, as recommended by Supervisor Gayle B. Uilkema.   C. 47 APPOINT Theresa Speiker to the First 5 Contra Costa Children and Families Commission, Employment and Human Services Director seat, as recommended by the County Administrator.   C. 48 REAPPOINT Christopher Learned to the County, School District and Community College District seat, Bill Clark to the County Superintendent of Schools seat and Alfred Granzella to the Special District seat on the Treasury Oversight Committee, as recommended by the Internal Operations Committee.   Appropriation Adjustments   C. 49 Sheriff-Coroner (0255, 0129):  APPROVE Appropriations and Revenue April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 8 C. 49 Sheriff-Coroner (0255, 0129):  APPROVE Appropriations and Revenue Adjustment No. 5053 authorizing new revenue in the amount of $90,569 from capital acquisition contributions made by the City of Oakley and appropriating it to the Sheriff's Information Technology Division for the purchase of East Bay Regional Communications System-compliant radio equipment for the City of Oakley.   Intergovernmental Relations   C. 50 AUTHORIZE the Chair of the Board to sign a letter of support to the Delta Protection Commission regarding the Delta Regional Flood Response Project, as recommended by the Transportation, Water and Infrastructure Committee.   C. 51 AUTHORIZE the Chair of the Board to send a letter to the state requesting levee improvement funding for three specific projects, as recommended by the Transportation, Water and Infrastructure Committee.   C. 52 ADOPT positions on various state bills as specified in the report, as recommended by the Legislation Committee.   Personnel Actions   C. 53 ADOPT Position Adjustment Resolution Number 21062 to add one permanent full-time Staff Development Supervisor position (represented)  in the Employment and Human Services Department. (90% Federal/State and 10% County).   C. 54 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21076, to add two part-time Physical Therapist II positions (represented) at and cancel one full-time Physical Therapist II position (represented) in the Health Services Department. (50% County, 50% California Children's Services Funds)   C. 55 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21068 to add one Account Clerk Advanced (represented) position and cancel one Clerical Supervisor (represented) position, in the Department of Child Support Services. (Cost savings)   C. 56 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21077 to add one Registered Nurse-Experienced Level position (represented) in the Health Services Department. (100% CCHP Enterprise Fund III)   C. 57 ADOPT Position Adjustment Resolution No. 21078, to add one Public Health Program Specialist I (represented) position and cancel a vacant Developmental Program Supervisor (represented) position in the Health Services Department. (100% Ryan White Part A/Prevention Program funds)   Grants & Contracts   April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 9 APPROVE and AUTHORIZE execution of agreements between the County and the following agencies for receipt of fund and/or services:   C. 58 APPROVE and AUTHORIZE the Sheriff-Coroner, or designee, to execute a contract with the City of Rio Vista, including mutual indemnification, to pay the County an amount not to exceed $625,000 to provide police dispatching services for the period January 1, 2012 through December 31, 2017.  (100% cost reimbursement by the City of Rio Vista)   C. 59 APPROVE and AUTHORIZE the Employment & Human Services Director, or designee, to execute a contract amendment with the Contra Costa Community College District, to increase the amount payable to the County by $32,684 for an amount not to exceed $1,153,796 for State Preschool services with no change to the term July 1, 2011 through June 30, 2012. (No County match)   C. 60 APPROVE and AUTHORIZE the Conservation and Development Director, or designee, to execute a contract amendment with Pacific Gas and Electric Company (PG&E), effective May 1, 2012,  to include current billing rates for building inspection services for the Gateway Generating Station, with no change in the original term of September 1, 2001. (100% Building Inspection Fee revenue)   APPROVE and AUTHORIZE execution of agreement between the County and the following parties as noted for the purchase of equipment and/or services:   C. 61 APPROVE and AUTHORIZE the County Administrator, or designee, to execute a contract with Buck Consultants in an amount not to exceed $200,000 for pension plan consulting for the period of July 1, 2012 through June 30, 2014. (Surcharges to all departments)   C. 62 APPROVE and AUTHORIZE the County Administrator, or designee, to execute a contract amendment/extension with Buck Consultants to increase the payment limit by $40,000 to a new payment limit of $370,000 for benefit design consulting and to extend the contract period from April 30, 2012 to October 31, 2012, as recommended by the County Administrator. (Surcharges to all departments)   C. 63 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Director, or designee, to execute a contract with the California State Association of Counties in an amount not to exceed $137,825 to administer computerized data processing services used by the welfare departments of the eighteen member county consortium for the period of July 1, 2012 through June 30, 2013. (93% State, 7% County)   C. 64 APPROVE and AUTHORIZE the Auditor-Controller, or designee, to execute on April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 10 C. 64 APPROVE and AUTHORIZE the Auditor-Controller, or designee, to execute on behalf of the County a contract amendment with ADP Inc., to increase the payment limit by $25,000 to a new payment limit of $3,141,400 with no change in the term of January 18, 2011 through January 18, 2016, to provide the automated timekeeping hardware, software and professional service for the Time and Labor Management/Hosting Project. (User Departments)     C. 65 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Daniel Yahya, M.D., in an amount not to exceed $274,400, to provide outpatient psychiatric services, for the period May 1, 2012 through April 30, 2013. (100% Mental Health Realignment)   C. 66 APPROVE and AUTHORIZE the Auditor-Controller, or designee, to pay each of up to eleven In-Home Supportive Services Public Authority Advisory Council members $24 per meeting to defray meeting attendance costs, not to exceed 3 meetings per month and a total costs not to exceed $9,504 for a period July 1, 2012 through June 30, 2013 recommended by the Employment and Human Services Director. (26.5% County, Federal 26.5%, State 47%)   C. 67 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Sharlene R. Speights, MFT, in an amount not to exceed $150,000, to provide professional outpatient psychotherapy services for Contra Costa Health Plan members, for the period May 1, 2012 through April 30, 2014. (100% Members Premiums)   C. 68 APPROVE and AUTHORIZE the Risk Manager to execute a contract amendment with Essential Staffing, Inc. to increase the payment limit by $100,000 to a new payment limit of $633,338 for additional workers' compensation staffing services during the term of July 1, 2011 through June 30, 2012. (100% Workers' Compensation Internal Service Funds)   C. 69 APPROVE and AUTHORIZE the Employment and Human Services Director, or designee, to execute a contract with Medtox Laboratories, Inc., in an amount not to exceed $225,000, to provide child welfare mandated drug testing services for the period July 1, 2012 through June 30, 2013. (30% County, 70% State)    C. 70 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Michael David Kassels, DO, in an amount not to exceed $200,000, to provide professional primary care services for Contra Costa Health Plan members, for the period June 1, 2012 through May 31, 2013. (100% Members Premiums)   C. 71 AWARD a construction contract to W.A. Thomas Company, Inc., the lowest April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 11 C. 71 AWARD a construction contract to W.A. Thomas Company, Inc., the lowest responsive and responsible bidder,  in the amount of $3,820,000 for the new Martinez Wellness Center at the Contra Costa Regional Medical Center campus, 2500 Alhambra Avenue, Martinez, for the Health Services Department. AUTHORIZE the Director of Public Works, or designee, to execute the contract. (Health Resources and Services Administration Grant, Enterprise 1 Fund Capital Budget)   C. 72 AWARD a construction contract to W.A. Thomas Company, Inc., the lowest responsive and responsible bidder,  in the amount of $2,958,000 for the new Crisis Residential Facility, 20 Allen Street, Martinez, for the Health Services Department. AUTHORIZE the Director of Public Works, or designee, to execute the contract. (100% Mental Health Services Fund)   C. 73 APPROVE and AUTHORIZE the Public Works Director, or designee, to execute a contract amendment with Terri Oyarzun (dba) Goats R Us to increase the payment limit by $200,000 to an amount not to exceed $250,000, for the period beginning June 1, 2011 through May 31, 2014, Countywide. (100% Flood Control Zone 3B Funds)   C. 74 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract amendment with Sarcom, Inc. (dba The Abreon Group), effective April 1, 2012, to increase the payment limit by $13,239, to a new payment limit of $224,939 for additional consultation and technical assistance with regard to communications plans for the Epic Electronic Health Record Project, with no change in the original term of August 15, 2011 through August 15, 2012. (100% Federal Funds)   C. 75 APPROVE and AUTHORIZE the Department of Conservation and Development Director, or designee, to execute a contract with Environmental Science Associates, Inc. (ESA) in an amount not to exceed $217,735 for the Keller Canyon landfill Land Use Permit Amendment application Environmental Impact Report for the period April 24, 2012 to March 31, 2013. (100% Land Use Permit fees)   C. 76 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with the County of Santa Clara, in an amount not to exceed $95,000, for the provision of inpatient mental health services to Contra Costa County inmates housed in module 8A of the Santa Clara main jail, for the period from July 1, 2012 through June 30, 2013. (100% Enterprise I funds)   C. 77 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, or designee, to execute a purchase order amendment with Graybar Electric Company, on behalf of the Chief Information Officer, to increase the payment limit by $500,000 to a new payment limit of $1,000,000 for radio and telecommunications equipment as needed for the period of November 1, 2011 through December 31, 2012. (100% Department User fees)   April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 12 C. 78 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute a contract with Intratek Computer, Inc., in an amount not to exceed $260,000, to provide hardware and software support services, for the period January 1, 2012 through December 31, 2012. (100% Enterprise Fund I)   C. 79 APPROVE and AUTHORIZE the Purchasing Agent, or designee, to execute purchase change orders, on behalf of the Conservation and Development Department, with various companies in a total amount not to exceed $380,000 for materials necessary to provide home weatherization services. (100% Federal ARRA Grant)   Other Actions   C. 80 DECLARE and AUTHORIZE the Purchasing Agent , or designee, to dispose of fully depreciated vehicles and equipment no longer needed for public use as recommended by the Public Works Director. (No fiscal impact)   C. 81 APPROVE and AUTHORIZE the Agricultural Commissioner, or designee, to execute an agreement with the California Department of Food and Agriculture (CDFA), in an amount not to exceed $18,300 to reimburse the County for the Petroleum Products Program, for the period of July 1, 2012 through June 30, 2013.   C. 82 ACCEPT report on the proposed Metropolitan Transportation Commission (MTC) OneBayArea Grant (OBAG) program update and AUTHORIZE the Chair of the Board of Supervisors to sign the attached response to the OBAG program update, as recommended by the Transportation, Water and Infrastructure Committee. (No fiscal impact)   C. 83 APPROVE and AUTHORIZE the Health Services Director, or designee, to execute an Unpaid Student Training Agreement with Mt. Diablo Unified School District, to provide supervised field instruction at Contra Costa Regional Medical Center and Contra Costa Health Centers for Contractors medical assistant and surgical technician students, for the period April 17, 2012 through August 31, 2015. (No Fiscal Impact)   C. 84 ADOPT Resolution No. 2012/171 approving the Master Property Tax Transfer Agreement for the allocation of property taxes for County Service Area R-7. (No fiscal impact)   C. 85 ACCEPT the March 2012 update on the operations of the Employment and Human Services Department, Community Services Bureau, as recommended by the Employment and Human Services Department Director.   C. 86 ADOPT the County's 2012/13 State Controller's Recommended Budget Schedules for Countywide Funds and Special Districts, as recommended by the County Administrator.    April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 13 GENERAL INFORMATION The Board meets in all its capacities pursuant to Ordinance Code Section 24-2.402, including as the Housing Authority and the Successor Agency to the Redevelopment Agency. Persons who wish to address the Board should complete the form provided for that purpose and furnish a copy of any written statement to the Clerk. Any disclosable public records related to an open session item on a regular meeting agenda and distributed by the Clerk of the Board to a majority of the members of the Board of Supervisors less than 72 hours prior to that meeting are available for public inspection at 651 Pine Street, First Floor, Room 106, Martinez, CA 94553, during normal business hours. All matters listed under CONSENT ITEMS are considered by the Board to be routine and will be enacted by one motion. There will be no separate discussion of these items unless requested by a member of the Board or a member of the public prior to the time the Board votes on the motion to adopt.  Persons who wish to speak on matters set for PUBLIC HEARINGS will be heard when the Chair calls for comments from those persons who are in support thereof or in opposition thereto. After persons have spoken, the hearing is closed and the matter is subject to discussion and action by the Board.  Comments on matters listed on the agenda or otherwise within the purview of the Board of Supervisors can be submitted to the office of the Clerk of the Board via mail: Board of Supervisors, 651 Pine Street Room 106, Martinez, CA 94553; by fax: 925-335-1913. The County will provide reasonable accommodations for persons with disabilities planning to attend Board meetings who contact the Clerk of the Board at least 24 hours before the meeting, at (925) 335-1900; TDD (925) 335-1915. An assistive listening device is available from the Clerk, Room 106. Copies of taped recordings of all or portions of a Board meeting may be purchased from the Clerk of the Board.  Please telephone the Office of the Clerk of the Board, (925) 335-1900, to make the necessary arrangements.   Forms are available to anyone desiring to submit an inspirational thought nomination for inclusion on the Board Agenda. Forms may be obtained at the Office of the County Administrator or Office of the Clerk of the Board, 651 Pine Street, Martinez, California. Applications for personal subscriptions to the weekly Board Agenda may be obtained by calling the Office of the Clerk of the Board, (925) 335-1900. The weekly agenda may also be viewed on the County’s Internet Web Page:  www.co.contra-costa.ca.us    STANDING COMMITTEES The Airport Committee (Supervisors Karen Mitchoff and Mary N. Piepho) meets on the fourth Monday of the month at 12:30 p.m. at Director of Airports Office, 550 Sally Ride Drive, Concord. April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 14 The Family and Human Services Committee (Supervisors Gayle B. Uilkema and Federal D. Glover) meets on the first Monday of the month at 1:30 p.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Finance Committee (Supervisors John Gioia and Federal D. Glover) meets on the second Monday of the month at 1:30 p.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Internal Operations Committee (Supervisors Mary N. Piepho and John Gioia) meets on the second Monday of the month at 9:00 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Legislation Committee (Supervisors Mary N. Piepho and Karen Mitchoff) meets on the first Thursday of the month at 11:00 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Public Protection Committee (Supervisors Federal D. Glover and Gayle B. Uilkema) meets on the first Monday of the month at 11:00 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez. The Transportation, Water & Infrastructure Committee (Supervisors Mary N. Piepho and Federal D. Glover) meets on the first Thursday of the month at 9:30 a.m. in Room 101, County Administration Building, 651 Pine Street, Martinez.   Airports Committee  TBD  TBD See above Family & Human Services Committee May 7, 2012  1:30 PM See above Finance Committee  May 14, 2012  1:30 PM See above Internal Operations Committee  May 14, 2012  9:00 AM See above Legislation Committee  May 3, 2012  11:00 AM See above Public Protection Committee June 4, 2012  11:00 AM See above Transportation, Water & Infrastructure Committee  May 3, 2012  1:30 PM See above   PERSONS WHO WISH TO ADDRESS THE BOARD MAY BE LIMITED TO THREE (3) MINUTES AGENDA DEADLINE: Thursday, 12 noon, 12 days before the Tuesday Board meetings. April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 15 Glossary of Acronyms, Abbreviations, and other Terms (in alphabetical order): Contra Costa County has a policy of making limited use of acronyms, abbreviations, and industry-specific language in its Board of Supervisors meetings and written materials. Following is a list of commonly used language that may appear in oral presentations and written materials associated with Board meetings: AB Assembly Bill ABAG Association of Bay Area Governments ACA Assembly Constitutional Amendment ADA Americans with Disabilities Act of 1990 AFSCME  American Federation of State County and Municipal Employees AICP American Institute of Certified Planners AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome ALUC Airport Land Use Commission AOD  Alcohol and Other Drugs ARRA  American Recovery & Reinvestment Act of 2009 BAAQMD Bay Area Air Quality Management District BART Bay Area Rapid Transit District BayRICS Bay Area Regional Interoperable Communications System BCDC Bay Conservation & Development Commission BGO  Better Government Ordinance BOS Board of Supervisors CALTRANS  California Department of Transportation CalWIN California Works Information Network CalWORKS California Work Opportunity and Responsibility to Kids CAER Community Awareness Emergency Response CAO  County Administrative Officer or Office CCCPFD (ConFire) Contra Costa County Fire Protection District CCHP Contra Costa Health Plan CCTA Contra Costa Transportation Authority CCRMC Contra Costa Regional Medical Center CCWD Contra Costa Water District CDBG Community Development Block Grant CFDA Catalog of Federal Domestic Assistance CEQA California Environmental Quality Act CIO Chief Information Officer COLA Cost of living adjustment ConFire (CCCFPD) Contra Costa County Fire Protection District CPA Certified Public Accountant CPI Consumer Price Index CSA County Service Area CSAC California State Association of Counties CTC California Transportation Commission dba doing business as EBMUD East Bay Municipal Utility District ECCFPD East Contra Costa Fire Protection District EIR Environmental Impact Report EIS Environmental Impact Statement EMCC Emergency Medical Care Committee EMS Emergency Medical Services EPSDT  Early State Periodic Screening, Diagnosis and Treatment Program (Mental Health) et al. et alii (and others) FAA Federal Aviation Administration FEMA  Federal Emergency Management Agency F&HS Family and Human Services Committee First 5 First Five Children and Families Commission (Proposition 10) FTE Full Time Equivalent FY Fiscal Year GHAD Geologic Hazard Abatement District GIS Geographic Information System HCD  (State Dept of) Housing & Community Development HHS (State Dept of ) Health and Human Services HIPAA  Health Insurance Portability and Accountability Act HIV Human Immunodeficiency Syndrome HOV High Occupancy Vehicle HR  Human Resources HUD  United States Department of Housing and Urban Development IHSS In-Home Supportive Services Inc. Incorporated IOC Internal Operations Committee ISO Industrial Safety Ordinance JPA Joint (exercise of) Powers Authority or Agreement Lamorinda Lafayette-Moraga-Orinda Area LAFCo  Local Agency Formation Commission LLC Limited Liability Company LLP Limited Liability Partnership Local 1 Public Employees Union Local 1 LVN Licensed Vocational Nurse MAC Municipal Advisory Council MBE Minority Business Enterprise M.D. Medical Doctor M.F.T. Marriage and Family Therapist MIS Management Information System MOE Maintenance of Effort MOU Memorandum of Understanding MTC Metropolitan Transportation Commission NACo National Association of Counties NEPA National Environmental Policy Act OB-GYN Obstetrics and Gynecology O.D. Doctor of Optometry April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 16 OES-EOC  Office of Emergency Services-Emergency Operations Center OPEB Other Post Employment Benefits OSHA Occupational Safety and Health Administration PARS Public Agencies Retirement Services Psy.D. Doctor of Psychology RDA Redevelopment Agency RFI Request For Information RFP Request For Proposal RFQ Request For Qualifications RN Registered Nurse SB  Senate Bill SBE Small Business Enterprise SEIU Service Employees International Union SUASI  Super Urban Area Security Initiative SWAT  Southwest Area Transportation Committee TRANSPAC Transportation Partnership & Cooperation (Central) TRANSPLAN Transportation Planning Committee (East County) TRE or TTE Trustee TWIC Transportation, Water and Infrastructure Committee UASI  Urban Area Security Initiative VA Department of Veterans Affairs vs. versus (against) WAN Wide Area Network WBE Women Business Enterprise WCCTAC West Contra Costa Transportation Advisory Committee April 24, 2012 Contra Costa County Board of Supervisors 17